DALSWINTON WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | DALSWINTON WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC279014 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DALSWINTON WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 4th Floor 12 Blenheim Place EH7 5JH Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DALSWINTON WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour DALSWINTON WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 10 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 24 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 10 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour DALSWINTON WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de John David Mills en tant que directeur le 31 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
legacy | pages | ANNOTATION | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2024 | 30 pages | AA | ||
legacy | 102 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Changement d'adresse du siège social de Fourth Floor 12 Blenheim Place Edinburgh EH7 5JH Scotland à 4th Floor 12 Blenheim Place Edinburgh EH7 5JH le 04 sept. 2025 | 1 pages | AD01 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Cessation de la nomination de Ian James Urquhart en tant que directeur le 28 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023 | 24 pages | AA | ||
legacy | 59 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Nomination de Ms Emily Rose Sale en tant qu'administrateur le 13 juin 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Rui Jorge Maia Da Silva en tant que directeur le 13 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Ian James Urquhart en tant qu'administrateur le 06 juin 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr John David Mills en tant qu'administrateur le 06 juin 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Pablo Andres en tant que directeur le 06 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Burness Paull Llp en tant que secrétaire le 10 juin 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Changement d'adresse du siège social de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ Scotland à Fourth Floor 12 Blenheim Place Edinburgh EH7 5JH le 04 juin 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de Ranelagh Nominees Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 13 déc. 2023 | 1 pages | PSC07 | ||
Satisfaction de la charge SC2790140013 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge SC2790140011 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Qui sont les dirigeants de DALSWINTON WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE, Emily Rose | Administrateur | 12 Blenheim Place EH7 5JH Edinburgh 4th Floor United Kingdom | England | British | 312786440001 | |||||||||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Secrétaire | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | 201245430001 | |||||||||||||||
| BISSET, Graham Ferguson | Secrétaire | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive Northamptonshire United Kingdom | 194566220001 | |||||||||||||||
| CALDER, Samantha Jane | Secrétaire | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | British | 75830790003 | ||||||||||||||
| DONNELLY, Lawrence John Vincent | Secrétaire | Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House 200 Perthshire | British | 129227760001 | ||||||||||||||
| HARDMAN, Steven Neville | Secrétaire | 5th Floor, Quartermile Two 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh C/O Morton Fraser Llp | 221212680001 | |||||||||||||||
| LONG, Jacqueline | Secrétaire | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive United Kingdom | 204212740001 | |||||||||||||||
| BURNESS PAULL LLP | Secrétaire | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland |
| 274632130001 | ||||||||||||||
| HMS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | The Ca'D'Oro 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow | 900004320001 | |||||||||||||||
| MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 2 Lister Square Quartermile Two EH3 9GL Edinburgh 5th Floor Scotland |
| 95512800001 | ||||||||||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Administrateur | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | England | British | 294355310001 | |||||||||||||
| ALEXANDER, Fraser Mcgregor | Administrateur | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House | United Kingdom | British | 65278040002 | |||||||||||||
| ANDRES, Pablo | Administrateur | 12 Blenheim Place EH7 5JH Edinburgh 4th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 276031210001 | |||||||||||||
| BAKER, Alan | Administrateur | 16 Harbourside Kip Village PA16 0BF Inverkip Renfrewshire | Scotland | Scottish | 103351610001 | |||||||||||||
| BOYD, Gordon Alexander | Administrateur | 50 Frederick Street EH2 1EX Edinburgh First Floor Scotland Scotland | England | British | 148856600001 | |||||||||||||
| BROWN, Katerina | Administrateur | 5th Floor, Quartermile Two 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh C/O Morton Fraser Llp | Scotland | British | 232165890001 | |||||||||||||
| COWIE, Steven Alexander | Administrateur | 42 Divert Road PA19 1EE Gourock | Scotland | British | 77680370001 | |||||||||||||
| DONALDSON, Peter Symons | Administrateur | PH16 5NF Pitlochry Clunie Power Station Perthshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131456210001 | |||||||||||||
| DOWLING, Paul Cyril | Administrateur | Weston Carrick Brook, Eadestown Naas County Kildare Ireland | Ireland | Irish | 111811130002 | |||||||||||||
| FLYNN, Donal Francis | Administrateur | 3 Whitebeam Avenue Clonskeagh IRISH Dublin 14 Ireland | Ireland | Irish | 126967800001 | |||||||||||||
| GIBBINS, Stewart Charles | Administrateur | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | United Kingdom | British | 148918290002 | |||||||||||||
| GIBLIN, Caoimhe Mary | Administrateur | Airtricity House Ravenscourt Office Park Sandyford Dublin 18 | Ireland | Irish | 153538670001 | |||||||||||||
| GREGSON, Paul Jonathan | Administrateur | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | England | British | 154908310001 | |||||||||||||
| GRIFFITHS, David Huw | Administrateur | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | United Kingdom | British | 177733400003 | |||||||||||||
| GUERIN, Daniel Joseph | Administrateur | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | England | Irish | 210311660001 | |||||||||||||
| HARDMAN, Steven Neville | Administrateur | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | Uk | British | 93743250007 | |||||||||||||
| HINTON, Thomas Edward | Administrateur | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 238940970001 | |||||||||||||
| JONES, Mark Richard | Administrateur | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | United Kingdom | British | 264835170001 | |||||||||||||
| LEE, Andrew William | Administrateur | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp United Kingdom | United Kingdom | British | 87527870001 | |||||||||||||
| MACHIELS, Eric Philippe Marianne, Dr | Administrateur | Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 England | United Kingdom | Belgium | 125748990001 | |||||||||||||
| MACKENZIE, Scott Leitch | Administrateur | 50 Frederick Street EH2 1EX Edinburgh First Floor Scotland Scotland | United Kingdom | British | 277478140001 | |||||||||||||
| MCADAM, Martin | Administrateur | 35 Glen Lawn Drive The Park IRISH Cabinteely Dublin Ireland | Irish | 94415780001 | ||||||||||||||
| MILLS, John David | Administrateur | 12 Blenheim Place EH7 5JH Edinburgh 4th Floor United Kingdom | Scotland | British | 162153070003 | |||||||||||||
| MURPHY, Senan | Administrateur | 2 Cranford Terenure Road West IRISH Dublin 6w Ireland | Irish | 95157200001 | ||||||||||||||
| NAGLE, Michael | Administrateur | 5th Floor, Quartermile Two 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh C/O Morton Fraser Llp | United Kingdom | British | 29436380007 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DALSWINTON WINDFARM (SCOTLAND) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobius Wind Holdings Limited | 15 août 2019 | St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mobius Wind Holdings Limited | 15 août 2019 | 133-137 Alexandra Road Wimbledon SW19 7JY London Connect House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Ranelagh Nominees Limited | 21 déc. 2017 | Gresham Street EC2V 7HN London 25 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Jupiter Acquisitions Limited | 21 déc. 2017 | 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London St Martin's House England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Natwest Fis Nominees Limited | 06 avr. 2016 | Devonshire Square COUTTS & C EC2M 4BA London 2 1/2 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0