DONSIDE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDONSIDE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC279243
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DONSIDE LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe DONSIDE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Sanctuary House 7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DONSIDE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HBJ 719 LIMITED01 févr. 200501 févr. 2005

    Quels sont les derniers comptes de DONSIDE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour DONSIDE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 mars 2022 au 30 sept. 2022

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2021

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2020

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2019

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Anthony Neil King en tant que directeur le 25 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Edward Henry Lunt en tant qu'administrateur le 22 mai 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Peter John Williams en tant qu'administrateur le 01 janv. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Craig Jon Moule en tant que directeur le 01 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    15 pagesAA

    Deuxième dépôt pour la cessation de fonctions de Craig Moule en tant que secrétaire

    5 pagesRP04TM02

    Deuxième dépôt pour la nomination de Mrs Nicole Seymour en tant que secrétaire

    6 pagesRP04AP03

    Cessation de la nomination de Craig Jon Moule en tant que secrétaire le 25 mai 2018

    1 pagesTM02
    Annotations
    DateAnnotation
    12 juil. 2018Second Filing The information on the form TM02 has been replaced by a second filing on 12/07/2018

    Nomination de Mrs Nicole Seymour en tant que secrétaire le 25 mai 2018

    2 pagesAP03
    Annotations
    DateAnnotation
    12 juil. 2018Second Filing The information on the form AP03 has been replaced by a second filing on 12/07/2018

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Sophie Atkinson en tant que secrétaire le 17 nov. 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Craig Jon Moule en tant que secrétaire le 17 nov. 2017

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de DONSIDE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SEYMOUR, Nicole
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    Secrétaire
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    246824440001
    LUNT, Edward Henry
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    Administrateur
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    EnglandBritishDirector258777900001
    WILLIAMS, Peter John
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    Administrateur
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    EnglandBritishDirector163514920001
    ATKINSON, Sophie
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    Secrétaire
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    190170780001
    MOULE, Craig Jon
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    Secrétaire
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    240635200001
    MOULE, Craig Jon
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    Secrétaire
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    173187820001
    HBJ SECRETARIAL LIMITED
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire désigné
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Midlothian
    900026260001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Mitre House
    United Kingdom
    Secrétaire
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Mitre House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement01447749
    111982890001
    BURT, Richard George Vincent
    The Old Rectory
    Burton Agnes
    YO25 4NB Driffield
    North Humberside
    Administrateur
    The Old Rectory
    Burton Agnes
    YO25 4NB Driffield
    North Humberside
    United KingdomBritishDirector65537860003
    GRANT, Alan Bryce
    Shop House
    Old Rayne
    AB52 6RY Insch
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Shop House
    Old Rayne
    AB52 6RY Insch
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishChief Executive62175950001
    HENDRY, Sylvia Margaret
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    Administrateur
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    ScotlandBritishCompany Director153666970002
    KING, Anthony Neil
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    Administrateur
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    EnglandBritishGroup Director - Capital Investment9255540009
    MARTIN, Peter Joseph
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    Administrateur
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector97475050001
    MCKINNON, John Strathdee
    21 Cava Close
    AB15 6WL Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    21 Cava Close
    AB15 6WL Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishGeneral Manager114336710001
    MOULE, Craig Jon
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    Administrateur
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Scotland
    EnglandBritishDirector135984850005
    MOULE, Craig Jon
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    Administrateur
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Director - Finance And Resources135984850003
    MURRAY, Alexander Birnie
    Burnhaven
    Strachan
    AB31 6NL Banchory
    Kincardineshire
    Administrateur
    Burnhaven
    Strachan
    AB31 6NL Banchory
    Kincardineshire
    United KingdomBritishChief Executive27214860003
    RUFF, Jeremy
    67 Ashmead Road
    Deptford
    SE8 4BY London
    Administrateur
    67 Ashmead Road
    Deptford
    SE8 4BY London
    United KingdomBritishCompany Director103688770001
    VAN DER LEE, Martinus Jacobus Maria
    23 Pitfour Court
    AB42 2YG Peterhead
    Aberdeenshire
    Administrateur
    23 Pitfour Court
    AB42 2YG Peterhead
    Aberdeenshire
    ScotlandDutchCarer70371220001
    HENDERSON BOYD JACKSON LIMITED
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur désigné
    Exchange Tower
    19 Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Midlothian
    900026250001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DONSIDE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Sanctuary Housing Association
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    England
    28 avr. 2016
    Castle Street
    WR1 3ZQ Worcester
    Chamber Court
    England
    Non
    Forme juridiqueRegistered Society
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCo-Operative And Community Benefit Societies Act 2014
    Lieu d'enregistrementFca Mutuals Public Register
    Numéro d'enregistrement19059r
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    DONSIDE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 22 mai 2012
    Livré le 07 juin 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Obligations in terms of the agreement
    Brèves mentions
    Several areas of ground at donside village, aberdeen, title number ABN14908.
    Personnes ayant droit
    • Chap Homes Limited
    Transactions
    • 07 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 13 mars 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 02 mai 2012
    Livré le 10 mai 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground at gordon mills road, aberdeen, known as the former donside paper mill aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Aberdeen City Council
    Transactions
    • 10 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 10 juin 2005
    Livré le 18 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The property known as donside paper mill, gordon mills road, aberdeen abn 14908.
    Personnes ayant droit
    • Adam & Company PLC
    Transactions
    • 18 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 31 mai 2005
    Livré le 04 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Adam & Company PLC
    Transactions
    • 04 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0