LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED

LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLABTECH HOLDING COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC283439
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ABZ GROUP LIMITED18 mai 200518 mai 2005
    FIRSTFORM (119) LIMITED19 avr. 200519 avr. 2005

    Quels sont les derniers comptes de LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    9 pages2.26B(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    22 pages2.16B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 12-16 Albyn Place Aberdeen AB10 1PS United Kingdom le 16 mars 2010

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Cessation de la nomination de Christopher Mcgeehan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Julie Cowie en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Burgess en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Bruce Gill en tant que directeur

    2 pagesTM01

    legacy

    1 pages225

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2008

    18 pagesAA

    legacy

    2 pages419b(Scot)

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2007

    21 pagesAA

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    legacy

    8 pages410(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    15 pages155(6)b

    legacy

    15 pages155(6)b

    legacy

    17 pages155(6)a

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'assistance financière pour l'acquisition d'actions

    RES07

    Qui sont les dirigeants de LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RAEBURN CHRISTIE CLARK & WALLACE
    12-16 Albyn Place
    AB10 1PS Aberdeen
    Secrétaire
    12-16 Albyn Place
    AB10 1PS Aberdeen
    35622500003
    ABERDEEN CONSIDINE & COMPANY
    8 &9 Bon Accord Crescent
    AB11 6DN Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    8 &9 Bon Accord Crescent
    AB11 6DN Aberdeen
    Aberdeenshire
    104774080001
    FIRSTSCOTTISH SECRETARIES LIMITED
    Bonnington Bond
    2 Anderson Place
    EH6 5NP Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    Bonnington Bond
    2 Anderson Place
    EH6 5NP Edinburgh
    Midlothian
    74658800001
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Secrétaire désigné
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    BRUCE, Andrew
    Strathnaver Station Road
    AB41 9AR Ellon
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Strathnaver Station Road
    AB41 9AR Ellon
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish45324080001
    BURGESS, John Graham
    4 Willow Tree Way
    AB31 5JQ Banchory
    Aberdeenshire
    Administrateur
    4 Willow Tree Way
    AB31 5JQ Banchory
    Aberdeenshire
    BanchoryBritish37612260003
    COWIE, Julie Elizabeth
    5 Hartington Road
    AB10 6XT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    5 Hartington Road
    AB10 6XT Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish111585570001
    FORBES, Robert Gordon
    7 Woodville Place
    SG14 3NX Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur
    7 Woodville Place
    SG14 3NX Hertford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish50248110002
    GARDINER, Jock Alistair
    The Pittodrie Coach House
    18 Ashley Lane
    AB10 6SW Aberdeen
    Administrateur
    The Pittodrie Coach House
    18 Ashley Lane
    AB10 6SW Aberdeen
    United KingdomBritish81169230001
    GILL, Bruce William
    22 Norman Gray Park
    AB21 0ZR Blackburn
    Aberdeenshire
    Administrateur
    22 Norman Gray Park
    AB21 0ZR Blackburn
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish118503010001
    MANSON, James
    13 St Keiran Crescent
    AB39 2GQ Stonehaven
    Kincardineshire
    Administrateur
    13 St Keiran Crescent
    AB39 2GQ Stonehaven
    Kincardineshire
    ScotlandBritish34380950003
    MCGEEHAN, Christopher
    131 Grandholm Drive
    Bridge Of Don
    AB22 8AE Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    131 Grandholm Drive
    Bridge Of Don
    AB22 8AE Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish118503110001
    FIRST SCOTTISH INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
    Bonnington Bond
    2 Anderson Place
    EH6 5NP Edinburgh
    Administrateur
    Bonnington Bond
    2 Anderson Place
    EH6 5NP Edinburgh
    91677020001

    LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 08 oct. 2007
    Livré le 11 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Merrill Lynch International Limited
    Transactions
    • 11 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 juin 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    Bond & floating charge
    Créé le 14 sept. 2007
    Livré le 03 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Merrill Lynch International
    Transactions
    • 03 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 13 mai 2005
    Livré le 02 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 02 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 juin 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 juin 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 13 mai 2005
    Livré le 24 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 mai 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 mai 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 mai 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 13 mai 2005
    Livré le 18 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Aberdeen Asset Managers Limited as Security Trustee
    Transactions
    • 18 mai 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 mai 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    LABTECH HOLDING COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 mars 2010Administration ended
    02 mars 2010Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Graham Douglas Frost
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    practitioner
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    John Bruce Cartwright
    Po Box 90
    Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    practitioner
    Po Box 90
    Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0