MAURICE MACNEILL IONA LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MAURICE MACNEILL IONA LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC284167 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MAURICE MACNEILL IONA LIMITED ?
| Adresse du siège social | 13 Whittingehame Drive G12 0XT Glasgow Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MAURICE MACNEILL IONA LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MAURICE MACNEILL IONA LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 30 avr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 14 mai 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 30 avr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MAURICE MACNEILL IONA LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2025 | 7 pages | AA | ||
Modification des détails de Wild Geese Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 août 2025 | 2 pages | PSC05 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2025 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2024 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023 | 7 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Janders and Flynn Limited en tant que secrétaire le 03 mars 2023 | 2 pages | AP04 | ||
Nomination de Mr Sam George Molyneux-Summers en tant qu'administrateur le 27 avr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Alexander Faulkner Partnership Limited en tant que secrétaire le 03 mars 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Alexander Faulkner le 02 mai 2023 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2022 | 18 pages | AA | ||
Notification de Wild Geese Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 juin 2022 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de Nicholas Alexander Faulkner en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 juin 2022 | 1 pages | PSC07 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2022 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 12 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA Scotland à 13 Whittingehame Drive Glasgow G12 0XT le 31 mars 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Notification de Nicholas Alexander Faulkner en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mars 2022 | 2 pages | PSC01 | ||
Cessation de Sdl Group Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 mars 2022 | 1 pages | PSC07 | ||
Cessation de la nomination de Helen Anne Ellis en tant que secrétaire le 28 mars 2022 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Catherine Staley en tant que directeur le 28 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Helen Anne Ellis en tant que directeur le 28 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Alexander Faulkner Partnership Limited en tant que secrétaire le 28 mars 2022 | 2 pages | AP04 | ||
Cessation de la nomination de Andrew Michael Deller en tant que directeur le 28 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Nicholas Alexander Faulkner en tant qu'administrateur le 31 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Paul Robert Gratton en tant que directeur le 28 oct. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de MAURICE MACNEILL IONA LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANDERS AND FLYNN LIMITED | Secrétaire | Tilford Street Tilford GU10 2AJ Farnham Cobbetts Corner Surrey England |
| 308967050001 | ||||||||||
| FAULKNER, Nicholas Alexander | Administrateur | Tilford Street Tilford GU10 2AJ Farnham Cobbetts Corner Surrey United Kingdom | England | British | 296045580001 | |||||||||
| MOLYNEUX-SUMMERS, Sam George | Administrateur | Amey Close Little Wratting CB9 7JZ Haverhill 6 England | England | British | 308966810001 | |||||||||
| CUTHBERTSON, Christine | Secrétaire | 26 Portree Avenue KA3 2GB Kilmarnock | British | 104303590001 | ||||||||||
| ELLIS, Helen Anne | Secrétaire | Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh 12 Scotland | 283536760001 | |||||||||||
| KINSEY, Hayley Rebecca | Secrétaire | Regan Way Beeston NG9 6RZ Nottingham 17 England | 267886510001 | |||||||||||
| MACDONALD, Morinne | Secrétaire désigné | Flat 3/2 30 Highburgh Road Dowanhill G12 9DZ Glasgow | British | 900017470001 | ||||||||||
| STALEY, Catherine Sara | Secrétaire | Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh 12 Scotland | 262901370001 | |||||||||||
| STALEY, Cathy Sara | Secrétaire | c/o Cathy Staley (Shepherd Direct Limited) Elmbank Gardens G2 4NQ Glasgow 1st Floor, Scotland | 187520660001 | |||||||||||
| TRAYNOR, Jim | Secrétaire | 20 Westbourne Drive G61 4BQ Glasgow | British | 76985630001 | ||||||||||
| TUCK, Sarah Kate | Secrétaire | Regan Way Chetwynd Business Park, Chilwell NG9 6RZ Nottingham 17 England | 245987110001 | |||||||||||
| ALEXANDER FAULKNER PARTNERSHIP LIMITED | Secrétaire | Little Park Farm Road PO15 5SN Fareham 11 Hampshire England |
| 202556880001 | ||||||||||
| ANDERTON, Colin James | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park, Chilwell NG9 6RZ Nottingham 17 England | England | British | 183725480001 | |||||||||
| CLIFFORD, Robert Martin | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park, Chilwell NG9 6RZ Nottingham 17 England | England | British | 177347450001 | |||||||||
| DELLER, Andrew Michael | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park, Chilwell NG9 6RZ Nottingham 17 England | England | British | 184200370001 | |||||||||
| ELLIS, Helen Anne | Administrateur | Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh 12 Scotland | United Kingdom | British | 287831100001 | |||||||||
| GRATTON, Paul Robert | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park, Chilwell NG9 6RZ Nottingham 17 England | England | British | 47117090005 | |||||||||
| HAMILTON, Lorraine | Administrateur | Graham Place G84 9EU Helensburgh 16 Argyll & Bute | Scotland | British | 139211190001 | |||||||||
| HICKLING, Christopher Charles | Administrateur | 3&4 Regan Way Chetwynd Business Park NG9 6RZ Chilwell 3&4 Nottingham England | England | British | 2439890001 | |||||||||
| LINDLEY, Patrick John | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park, Chilwell NG9 6RZ Nottingham 17 England | England | British | 91629130001 | |||||||||
| MACDONALD, Morinne | Administrateur désigné | Flat 3/2 30 Highburgh Road Dowanhill G12 9DZ Glasgow | Scotland | British | 900017470001 | |||||||||
| POLLOCK, Gail | Administrateur | 41 Ballantrae Drive Newton Mearns G77 5TB Glasgow | British | 95307160001 | ||||||||||
| SHARKEY, Lesley | Administrateur | The Cobbles Cuddington CW8 2XH Northwich 17 Cheshire | England | British | 133584100001 | |||||||||
| STALEY, Catherine | Administrateur | Regan Way Beeston NG9 6RZ Nottingham 17 England | England | British | 279177360001 | |||||||||
| SUMMERS, Christopher Mark | Administrateur | Regan Way Beeston NG9 6RZ Nottingham 17 England | England | British | 279178570001 | |||||||||
| TRAYNOR, James | Administrateur | 20 Westbourne Drive Bearsden G61 4BQ Glasgow Lanarkshire | British | 107396010001 | ||||||||||
| VOISEY, Mark Jason | Administrateur | Bank House Goldford Lane SY14 8LL Malpas Cheshire | British | 105968780001 | ||||||||||
| WHITE, Stuart | Administrateur | 349 Bath Street G2 4AA Glasgow Venlaw House Scotland | Scotland | British | 104303580002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MAURICE MACNEILL IONA LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lithos Real Estate Ltd | 07 juin 2022 | Hewshott Lane GU30 7SU Liphook Adventure Hampshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Nicholas Alexander Faulkner | 28 mars 2022 | Little Park Farm Road PO15 5SN Fareham 11 England | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Sdl Group Holdings Limited | 31 janv. 2021 | Regan Way Beeston NG9 6RZ Nottingham 17 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Sdl Property Services Group Limited | 06 avr. 2016 | Regan Way Chilwell, Beeston NG9 6RZ Nottingham 3 & 4 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0