EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC285404 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 12 août 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 26 août 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 12 août 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2025 | 19 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 août 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Dylan Fletcher en tant que directeur le 12 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Alison Groat en tant que directeur le 12 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Craig Alexander Thomson en tant qu'administrateur le 12 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mrs Claire Agnes Mcinally en tant qu'administrateur le 12 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Modification des détails de Pfi Infrastructure Finance Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 févr. 2025 | 2 pages | PSC05 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Infrastructure Managers Limited le 17 févr. 2025 | 1 pages | CH04 | ||
Cessation de la nomination de Martin Timothy Smith en tant que directeur le 31 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Cameron Mclure en tant qu'administrateur le 31 janv. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2024 | 19 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 août 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de David Niall Smith en tant que directeur le 20 févr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Ms Alison Groat en tant qu'administrateur le 20 févr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Alasdair Campbell en tant que directeur le 09 févr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Neil Andrew Woodburn en tant qu'administrateur le 09 févr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Infrastructure Managers Limited le 15 déc. 2023 | 1 pages | CH04 | ||
Changement d'adresse du siège social de Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN United Kingdom à C/O Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN le 12 déc. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Changement d'adresse du siège social de C/O Infrastructure Managers Limited 2nd Floor 11 Thistle Street Edinburgh EH2 1DF à Infrastructure Managers Limited 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EN le 12 déc. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2023 | 21 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 25 juil. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de John Wrinn en tant que directeur le 30 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Carl Harvey Dix en tant qu'administrateur le 30 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2022 | 21 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED | Secrétaire | 6 Kean Street WC2B 4AS London 8th Floor United Kingdom |
| 128530180002 | ||||||||||
| CAVILL, John Ivor | Administrateur | 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh C/O Infrastructure Managers Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 152521640006 | |||||||||
| DIX, Carl Harvey | Administrateur | 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh C/O Infrastructure Managers Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 305019190001 | |||||||||
| DONN, Michael Andrew | Administrateur | 40 Princes Street EH2 2BY Edinburgh Aberdeen Asset Management Plc United Kingdom | Scotland | British | 108352120001 | |||||||||
| HEATH, James Christopher | Administrateur | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 122413700002 | |||||||||
| MCINALLY, Claire Agnes | Administrateur | Pirnhall Business Park FK7 8HW Stirling Forth House United Kingdom | United Kingdom | British | 167317960001 | |||||||||
| MCLURE, Cameron | Administrateur | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 318253280001 | |||||||||
| THOMSON, Craig Alexander | Administrateur | Pirnhall Business Park FK7 8HW Stirling Forth House United Kingdom | United Kingdom | British | 170356700001 | |||||||||
| WOODBURN, Neil Andrew | Administrateur | 2nd Floor Drum Suite, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh C/O Infrastructure Managers Limited United Kingdom | England | British | 137607780003 | |||||||||
| SMYTH, Pamela June | Secrétaire | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh Lothian | British | 65057960002 | ||||||||||
| WILSON, Gordon James | Secrétaire | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh Lothian | British | 169498380001 | ||||||||||
| BURNESS LLP | Secrétaire | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 99448920001 | |||||||||||
| ANDERSON, Derek Orr | Administrateur | 9 The Spinneys KY11 9SL Dalgety Bay Fife | Scotland | British | 161345590001 | |||||||||
| BAXTER, Mark | Administrateur | Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh 2 Midlothian | United Kingdom | British | 121315740001 | |||||||||
| BRADLEY, Victoria Louise | Administrateur | Churchill Place E14 5HP London 1 | United Kingdom | British | 150074660001 | |||||||||
| BREMNER, Alexander George | Administrateur | c/o Infrastructure Managers Limited Floor 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd United Kingdom | Scotland | British | 152806580003 | |||||||||
| BREMNER, Alexander George | Administrateur | Inch Avenue Aberdour KY3 0TF Burntisland 3 Fife | Scotland | British | 152806580001 | |||||||||
| BRUCE, Andrew David | Administrateur | 147 Constitution Street EH6 7AD Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 111589290001 | |||||||||
| CAMPBELL, Alasdair | Administrateur | Level 7 One Bartholomew Close, Barts Square ECA 7BL London Infrared Capital Partners Limited United Kingdom | Scotland | British | 215915630001 | |||||||||
| ELLIOT, John Christian | Administrateur | 1 Hope Terrace EH9 2AP Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 184790001 | |||||||||
| FLETCHER, Dylan | Administrateur | Croftlea 50 Kenilworth Road Bridge Of Allan FK9 4RS Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 82097010004 | |||||||||
| GARCIA, Carlos Abuin | Administrateur | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | Spanish | 239719320001 | |||||||||
| GILLESPIE, Kenneth William | Administrateur | 7 Shaws Crescent EH26 0RE Milton Bridge Midlothian | Scotland | British | 105139700001 | |||||||||
| GILMOUR, David Fulton | Administrateur | c/o Infrastructure Managers Limited Floor 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd | United Kingdom | British | 158508150001 | |||||||||
| GROAT, Alison | Administrateur | Pirnhall Business Park FK7 8HW Stirling Forth House United Kingdom | Scotland | British | 316594510001 | |||||||||
| HOLDEN, Mark Geoffrey David | Administrateur | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 Uk | England | British | 170508700001 | |||||||||
| JACK, Ronald Gilfillan | Administrateur | c/o Infrastructure Managers Limited Floor 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd United Kingdom | Scotland | British | 76530270002 | |||||||||
| MACKIE, Robin Smith | Administrateur | Katiesdyke New Fargie PH2 9QT Glenfarg Perthshire | Scotland | British | 522870002 | |||||||||
| MCVEY, Philip | Administrateur | Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh 2 Midlothian | United Kingdom | British | 99001530002 | |||||||||
| PARK, James Leil | Administrateur | Westfield 8 Donaldfield Road PA11 3JJ Bridge Of Weir Renfrewshire | Scotland | British | 114897490001 | |||||||||
| QUAIFE, Geoffrey Alan | Administrateur | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 Uk | United Kingdom | British | 123048390001 | |||||||||
| RITCHIE, Alan Campbell | Administrateur | 57 Kettilstoun Mains EH49 6SH Linlithgow West Lothian | United Kingdom | British | 241898940001 | |||||||||
| RITCHIE, Alan Campbell | Administrateur | 57 Kettilstoun Mains EH49 6SH Linlithgow West Lothian | United Kingdom | British | 241898940001 | |||||||||
| SCOTT, Alan Philip | Administrateur | Harlaw Bank Balerno EH14 7HR Edinburgh 2 | Scotland | British | 182952430001 | |||||||||
| SMITH, David Niall | Administrateur | Pirnhall Business Park FK7 8HW Stirling Forth House United Kingdom | United Kingdom | British | 197175530001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EMBLEM SCHOOLS (HOLDINGS) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfi Infrastructure Finance Limited | 06 avr. 2016 | 6 Kean Street WC2B 4AS London 8th Floor United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Aberdeen Infrastructure (No.3) Limited | 06 avr. 2016 | Churchill Place Canary Wharf E14 5HJ London 20 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Infrastructure Investments Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0