D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED

D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéD.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC286340
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cromwell Property Group Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VALAD CONTINENTAL PARTNERS LIMITED18 sept. 200718 sept. 2007
    TEESLAND CONTINENTAL PARTNERS LIMITED24 mai 200724 mai 2007
    SCARBOROUGH CONTINENTAL PARTNERS LIMITED30 juin 200530 juin 2005
    SCARBOROUGH CONTINENTAL PARTNERS TOPCO LIMITED23 juin 200523 juin 2005
    M M & S (4085) LIMITED17 juin 200517 juin 2005

    Quels sont les derniers comptes de D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    14 pagesLIQ13(Scot)
    YAILBSLN

    Modification des coordonnées du secrétaire Cromwell Corporate Secretarial Limited le 07 sept. 2020

    1 pagesCH04
    X9D7QVT5

    Changement d'adresse du siège social de 1st Floor Exchange Place 3 3 Semple Street Edinburgh EH3 8BL à Cromwell Property Group Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square 92-98 Fountainbridge Edinburgh EH3 9QA le 07 sept. 2020

    1 pagesAD01
    X9D2CBAX

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 janv. 2020

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 16 janv. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X8X3FUI9

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04
    X8I6G2KX

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04
    X8I6FUK0

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    2 pagesMR04
    X8I6FVCO

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04
    X8I6FVQA

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04
    X8I6G461

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04
    X8I6FXRK

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04
    X8I6FZ17

    Satisfaction de la charge SC2863400011 en totalité

    1 pagesMR04
    X8I6G7DD

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04
    X8I6G535

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04
    X8I6FZV7

    Satisfaction de la charge SC2863400010 en totalité

    1 pagesMR04
    X8I6G6B7

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018

    20 pagesAA
    A8EOG7PL

    Période comptable précédente prolongée du 30 juin 2018 au 31 déc. 2018

    1 pagesAA01
    X813X1IA

    Nomination de Mr James Edward Maddy en tant qu'administrateur le 15 févr. 2019

    2 pagesAP01
    X7ZCD6F4

    Cessation de la nomination de Claire Treacy en tant que directeur le 15 févr. 2019

    1 pagesTM01
    X7ZCD6D4

    Déclaration de confirmation établie le 16 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X7XCT42H

    Comptes annuels établis au 30 juin 2017

    28 pagesAA
    S72Q8DH6

    Déclaration de confirmation établie le 16 janv. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    X6XQ2DG8

    Déclaration de confirmation établie le 17 juin 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01
    X694NND7

    Qui sont les dirigeants de D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    Cromwell Property Group
    United Kingdom
    Secrétaire
    Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    Cromwell Property Group
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrementSC219311
    133355520004
    MADDY, James Edward
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Fund Accounting137459000002
    CROMWELL DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement5307786
    102622300003
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    DARLING, Andrew David
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    BritishBanker73218540001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishSolicitor1267050001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritishDirector1267050001
    GERVASI, Pierre Rene
    19 Rue Suzanne
    95600 Eaubonne
    FOREIGN France
    Administrateur
    19 Rue Suzanne
    95600 Eaubonne
    FOREIGN France
    FrenchBanker111647700001
    HURLEY, Peter Edmund
    Nield Avenue
    NSW 2093 Balgowlah
    16
    Australia
    Administrateur
    Nield Avenue
    NSW 2093 Balgowlah
    16
    Australia
    AustraliaAustralianCompany Director121515110004
    KENNEDY, Johann
    46 Cammo Gardens
    EH4 8EG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    46 Cammo Gardens
    EH4 8EG Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishBanker119260990001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director56953000002
    MCCABE, Gary John
    Deutschherrnufer 45
    Frankfurt Am Main
    60594
    Germany
    Administrateur
    Deutschherrnufer 45
    Frankfurt Am Main
    60594
    Germany
    BritishDirector133465930001
    MCCABE, Kevin Charles
    Level 20
    5 Place Du Champs De Mars
    1050 Brussels
    Bastion Tower
    Belgium
    Administrateur
    Level 20
    5 Place Du Champs De Mars
    1050 Brussels
    Bastion Tower
    Belgium
    BelgiumBritishChartered Surveyor109250000002
    MCCARTHY, Martyn James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomAustralianCeo Europe126149680033
    MCDONALD, Derek
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    Administrateur
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    ScotlandBritishBanker190466700001
    MORE, Gordon Lennie Truman
    Paseo De Peru 51 Cuidalcampo
    28707 Madrid
    Spain
    Administrateur
    Paseo De Peru 51 Cuidalcampo
    28707 Madrid
    Spain
    BritishBanker111414890001
    SEDDON, David Robert Armour
    81 East Sheen Avenue
    SW14 8AX London
    Administrateur
    81 East Sheen Avenue
    SW14 8AX London
    England & WalesBritishDirector141822480001
    SHIELS, Paul
    Level 1,Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Uberior Europa Ltd
    Administrateur
    Level 1,Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Uberior Europa Ltd
    GermanyBritishDirector Joint Ventures Europe136589450001
    SIME, Fraser Mckenzie
    115 Meadowspot
    EH10 5UY Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    115 Meadowspot
    EH10 5UY Edinburgh
    Midlothian
    BritishBanker111866670001
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Administrateur
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritishChartered Surveyor69909950001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrishChief Financial Officer189529610001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur désigné
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur désigné
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    D.U.K.E. Property Holdings (Uk) Limited
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    06 avr. 2016
    Manor Court Business Park
    Eastfield
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor, Unit 16
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement4382219
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 03 févr. 2015
    Livré le 19 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 03 févr. 2015
    Livré le 19 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge
    Créé le 23 mars 2012
    Livré le 29 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Right, title and interest in the charged assets. See form for further details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 13 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 23 mars 2012
    Livré le 29 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 13 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 mars 2012
    Livré le 02 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 13 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee and debenture
    Créé le 01 juil. 2009
    Livré le 13 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery - see form 410 for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 juil. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 janv. 2017Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 13 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 01 juil. 2009
    Livré le 13 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 juil. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Pledge over receivables agreement
    Créé le 27 févr. 2008
    Livré le 14 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The pledged receivables.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 mars 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 21 oct. 2005
    Livré le 08 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1 ordinary £1 share in scarborough continental partners UK limited and all further or additional stocks, shares and other securities. All dividends, interest or distribution.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge
    Créé le 21 oct. 2005
    Livré le 04 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The existing shares and any assets to which the company is entitled at the date of the share pledge any other further shares and/or assets to which the company becomes entitled after the date of the share pledge in accordance with the provisions of the share pledge.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 21 oct. 2005
    Livré le 29 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 oct. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)

    D.U.K.E. CONTINENTAL PARTNERS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 mars 2022Due to be dissolved on
    23 janv. 2020Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0