KILMARTIN LONDON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKILMARTIN LONDON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC286515
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KILMARTIN LONDON LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe KILMARTIN LONDON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Maclay Murray & Spens Quartermile One
    15 Lauriston Place
    EH3 9EP Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de KILMARTIN LONDON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour KILMARTIN LONDON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 02 août 2011

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 juil. 2011

    État du capital au 19 juil. 2011

    • Capital: GBP 100
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG02s

    Période comptable précédente prolongée du 30 avr. 2010 au 31 oct. 2010

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 7 Castle Street Edinburgh EH2 3AH le 03 juin 2010

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    29 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Gordon Bennet en tant que directeur

    2 pagesTM01

    legacy

    7 pagesMG01s

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2009

    15 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de KILMARTIN LONDON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GROAT, Susan Elizabeth
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    7
    Administrateur
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    7
    ScotlandBritish88980540001
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Secrétaire
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    British562500001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BENNET, Gordon Iain
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    Dunbartonshire
    Administrateur
    East Clyde Street
    G84 7AX Helensburgh
    152
    Dunbartonshire
    United KingdomBritish60009740002
    BOWDER, Simon Hugo
    The Piggeries
    Hog Lane, Ashley Green
    HP5 3PS Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Piggeries
    Hog Lane, Ashley Green
    HP5 3PS Chesham
    Buckinghamshire
    British105270120001
    BRYAN, James Hamilton
    95 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Rutland
    Leicestershire
    Administrateur
    95 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Rutland
    Leicestershire
    United KingdomBritish149263980001
    KERR, Adam Charles
    Snail Hall Millwood Road
    Polstead
    CO6 5AU Colchester
    Essex
    Administrateur
    Snail Hall Millwood Road
    Polstead
    CO6 5AU Colchester
    Essex
    United KingdomBritish141326000001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Administrateur
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    United KingdomBritish83466350002
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Administrateur
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritish161858620001

    KILMARTIN LONDON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 11 févr. 2010
    Livré le 13 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ealing driving range rodwell road northolt agl 168302.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 22 juin 2007
    Livré le 02 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold property known as alwyn house, 31 windsor street, chertsey SY628602.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 juil. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 06 févr. 2007
    Livré le 14 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold/leasehold property known as land on west side of A1(m) at portobello, birtley & land to south east of portobello road, portobello, birtley TY200270 TY242181 TY142231.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 févr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 04 oct. 2006
    Livré le 06 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Freehold property known as 102-104 stewart's road, battersea, london SGL496907 SGL496908 SGL487455.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 11 juil. 2006
    Livré le 01 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land lying to north east of huntingdon road, boxworth end, swavesey, cambridgeshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 août 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 03 avr. 2006
    Livré le 06 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The freehold property known as land on the south side of bedford road, northampton nn 181537.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 29 mars 2006
    Livré le 05 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land and buildings lying to the west of dukinfield road, hyde, manchester (title number GM311806).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 10 nov. 2005
    Livré le 16 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The freehold property being land lying to the south east of bucking way road, swavesey known as phase ii of the anderson road and plot 9 buckingway business park, swavesey (title number CB298754).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Floating charge
    Créé le 31 oct. 2005
    Livré le 08 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Legal charge
    Créé le 28 oct. 2005
    Livré le 01 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All that leasehold property being land and buildings on the south east side of rowdell road northolt ngl 372347.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 05 août 2005
    Livré le 13 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over freehold property known as plot c, gunnels wood road, stevenage.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 août 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    KILMARTIN LONDON LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 mai 2012Dissolved on
    02 août 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0