BDL VENTURES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBDL VENTURES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC287558
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BDL VENTURES LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BDL VENTURES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    40 Brand Street
    Glasgow
    G51 1DG
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BDL VENTURES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 avr. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BDL VENTURES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BDL VENTURES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes consolidés établis au 28 avr. 2013

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 août 2013

    État du capital au 05 août 2013

    • Capital: GBP 1,002
    SH01

    État du capital après une attribution d'actions au 19 avr. 2013

    • Capital: GBP 1,002
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Capitalisation agreement/intercompany loan approved sect 190 19/04/2013
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Période comptable actuelle prolongée du 31 oct. 2012 au 30 avr. 2013

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Paul Johnston en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stewart Campbell en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Louis Woodcock en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes consolidés établis au 30 oct. 2011

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Louis Peter Woodcock le 15 juil. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stuart John Mccaffer le 15 juil. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Stuart John Mccaffer le 15 juil. 2011

    1 pagesCH03

    legacy

    2 pagesMG03s

    legacy

    4 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    2 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    Qui sont les dirigeants de BDL VENTURES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCCAFFER, Stuart John
    40 Brand Street
    Glasgow
    G51 1DG
    Secrétaire
    40 Brand Street
    Glasgow
    G51 1DG
    British64903230004
    CAMPBELL, Stewart
    40 Brand Street
    Glasgow
    G51 1DG
    Administrateur
    40 Brand Street
    Glasgow
    G51 1DG
    United KingdomBritish109131250002
    LAPPING, Andrew Christopher
    Hindley House
    Hindley Estate
    NE43 7SA Stocksfield
    Northumberland
    Administrateur
    Hindley House
    Hindley Estate
    NE43 7SA Stocksfield
    Northumberland
    United KingdomBritish113467730001
    MCCAFFER, Stuart John
    40 Brand Street
    Glasgow
    G51 1DG
    Administrateur
    40 Brand Street
    Glasgow
    G51 1DG
    ScotlandBritish64903230004
    JOHNSTON, Paul Mcphie
    7 Sutherland Avenue
    Pollokshields
    G41 4JJ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Sutherland Avenue
    Pollokshields
    G41 4JJ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish87082600003
    WOODCOCK, Louis Peter
    40 Brand Street
    Glasgow
    G51 1DG
    Administrateur
    40 Brand Street
    Glasgow
    G51 1DG
    United KingdomBritish39601150005

    BDL VENTURES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 07 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ewan Campbell
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • David George Thompson
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Stuart John Mccaffer
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Louis Peter Woodcock
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Simon Rogers
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Jonathan Horne
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Trustees of the Ac Lapping No.3 Life Interest Trust
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mark Shaw
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • John Boyle
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Paul Mcphie Johnston
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Trustees of the Ac Lapping No.2 Life Interest Trust
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • William Aitchison
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 sept. 2005
    Livré le 14 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Stewart Robertson
    Transactions
    • 14 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0