ALEXANDRA PARK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALEXANDRA PARK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC290789
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALEXANDRA PARK LIMITED ?

    • (8514) /

    Où se situe ALEXANDRA PARK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o DLA PIPER SCOTLAND LLP
    Collins House
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALEXANDRA PARK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RESONANZ LIMITED23 sept. 200523 sept. 2005

    Quels sont les derniers comptes de ALEXANDRA PARK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ALEXANDRA PARK LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ALEXANDRA PARK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Dla Piper Scotland Llp 249 West George Street Glasgow G2 4RB Uk à C/O Dla Piper Scotland Llp Collins House Rutland Square Edinburgh EH1 2AA le 12 mai 2015

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de David Charles Lovett en tant que directeur le 05 mai 2015

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Dla Piper Scotland Llp 249 West George Street Glasgow G2 4RB United Kingdom à 1206 Tollcross Road Glasgow Scotland G32 8HH le 03 nov. 2014

    2 pagesAD01
    Annotations
    DateAnnotation
    18 mars 2015Rectified Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of a change to the Registered Office have been removed as this was invalid or ineffective.

    Cessation de la nomination de Stephen Jonathan Taylor en tant que directeur le 31 déc. 9999

    3 pagesTM01
    Annotations
    DateAnnotation
    18 mars 2015Rectified Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s termination of appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    Cessation de la nomination de David Charles Lovett en tant que directeur le 31 oct. 2014

    3 pagesTM01
    Annotations
    DateAnnotation
    18 mars 2015Rectified Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s termination of appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    Nomination de Jeffrey Simpson en tant que secrétaire le 01 nov. 2014

    4 pagesAP03
    Annotations
    DateAnnotation
    18 mars 2015Rectified Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the secretary’s appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    Nomination de Elizabeth Madden en tant qu'administrateur le 01 nov. 2014

    AP01

    Nomination de Mr William Madden en tant qu'administrateur le 01 nov. 2014

    4 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    18 mars 2015Rectified Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    Nomination de Maureen Elizabeth Appleyard en tant qu'administrateur le 01 nov. 2014

    AP01
    Annotations
    DateAnnotation
    18 mars 2015Rectified Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    Nomination de Dr James Paton Murray en tant qu'administrateur le 01 nov. 2014

    4 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    18 mars 2015Rectified Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s appointment have been removed as this was invalid or ineffective.
    18 mars 2015Clarification Under Section 1095 of the Companies Act 2006, details of the director’s appointment have been removed as this was invalid or ineffective.

    legacy

    2 pagesAC93

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Francis Mccormack en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Timothy Bolot en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Charles Lovett en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Avis de la réalisation de l'accord amiable

    6 pages1.4(Scot)

    Avis du rapport de la réunion approuvant l'accord amiable avec les créanciers

    4 pages1.1(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de , C/O Southern Cross Healthcare, the Castle Business Park Lomond Court, Ground Floor Unit 2, Stirling, Scotland, FK9 4TU à C/O Dla Piper Scotland Llp 249 West George Street Glasgow G2 4RB le 20 janv. 2012

    1 pagesAD01

    legacy

    5 pagesMG04s

    Qui sont les dirigeants de ALEXANDRA PARK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Administrateur
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    United KingdomBritish163496070001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    158304660001
    MCLEISH, William David
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Secrétaire
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    British168970640001
    PARK, Neil
    108 Corbett Street
    G32 8LG Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    108 Corbett Street
    G32 8LG Glasgow
    Lanarkshire
    British95141670001
    PARK, Neil
    108 Corbett Street
    G32 8LG Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    108 Corbett Street
    G32 8LG Glasgow
    Lanarkshire
    British95141670001
    J.M.SIMPSON & CO
    1206 Tollcross Road
    G32 8HH Glasgow
    Strathclyde
    Secrétaire
    1206 Tollcross Road
    G32 8HH Glasgow
    Strathclyde
    76324870001
    J.M.SIMPSON & CO
    1206 Tollcross Road
    G32 8HH Glasgow
    Strathclyde
    Secrétaire
    1206 Tollcross Road
    G32 8HH Glasgow
    Strathclyde
    76324870001
    APPLEYARD, Maureen Elizabeth
    4 Craigmyle Gardens
    TD1 3LP Clovenfords
    Selkirkshire
    Administrateur
    4 Craigmyle Gardens
    TD1 3LP Clovenfords
    Selkirkshire
    UkBritish192316800001
    BOLOT, Timothy James
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Dla Piper Scotland Llp
    West George Street
    G2 4RB Glasgow
    249
    United Kingdom
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Administrateur
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    DONOGHUE, Alan Bell
    51 Egilsay Street
    G22 7RQ Glasgow
    Administrateur
    51 Egilsay Street
    G22 7RQ Glasgow
    British112734150001
    DONOHOE, Brian Harold
    5 Greenfield Drive
    KA12 0ED Irvine
    Ayreshire
    Administrateur
    5 Greenfield Drive
    KA12 0ED Irvine
    Ayreshire
    ScotlandBritish242888340002
    FOULKES, Kamma
    Bath Street
    G2 4HU Glasgow
    193-199
    Lanarkshire
    Administrateur
    Bath Street
    G2 4HU Glasgow
    193-199
    Lanarkshire
    United KingdomBritish111188390002
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Administrateur
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Administrateur
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritish34419700002
    MADDEN, Elizabeth
    102 Greenock Road
    KA30 8PG Largs
    Ayrshire
    Administrateur
    102 Greenock Road
    KA30 8PG Largs
    Ayrshire
    ScotlandBritish88192670001
    MADDEN, William
    102 Greenock Road
    KA30 8PG Largs
    Ayrshire
    Administrateur
    102 Greenock Road
    KA30 8PG Largs
    Ayrshire
    ScotlandBritish88192640001
    MIDMER, Richard Neil
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Administrateur
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Administrateur
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    MURRAY, James Paton, Dr
    Craigmyle Gardens
    Craigmyle Park
    TD1 3LP Clovenfords
    4
    Scottish Borders
    Uk
    Administrateur
    Craigmyle Gardens
    Craigmyle Park
    TD1 3LP Clovenfords
    4
    Scottish Borders
    Uk
    United KingdomBritish48415950003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    Administrateur
    c/o Southern Cross Healthcare
    Lomond Court
    Ground Floor Unit 2
    FK9 4TU Stirling
    The Castle Business Park
    Scotland
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Bath Street
    G2 4HU Glasgow
    193-199
    Lanarkshire
    Administrateur
    Bath Street
    G2 4HU Glasgow
    193-199
    Lanarkshire
    United KingdomBritish147997950001

    ALEXANDRA PARK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental legal mortgage
    Créé le 06 mai 2011
    Livré le 20 mai 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Alexandra park alexandra way newbiggin-by-the sea ND157495.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 17 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Supplemental legal mortgage
    Créé le 25 sept. 2009
    Livré le 07 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Alexandra park alexandra way newbiggin-by-the-sea northumberland ND157495.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 17 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Deed of accession and charge
    Créé le 16 janv. 2009
    Livré le 29 janv. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 nov. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    Legal charge
    Créé le 11 août 2006
    Livré le 16 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over land to north east of hazlewood avenue , known as the demolition field, newbiggin-by-the-sea.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 août 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 05 juil. 2006
    Livré le 08 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 juil. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    ALEXANDRA PARK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 août 2012Date of completion or termination of CVA
    20 juin 2012Date of meeting to approve CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    practitioner
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0