EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED

EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC291351
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cromwell Property Group Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KENMORE EUROPE LIMITED27 oct. 200527 oct. 2005
    DALGLEN (NO. 1006) LIMITED06 oct. 200506 oct. 2005

    Quels sont les derniers comptes de EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2022
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2023
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au07 janv. 2024
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation21 janv. 2024
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au07 janv. 2023
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Cromwell Corporate Secretarial Limited en tant que secrétaire le 24 déc. 2024

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Cromwell Director Limited en tant que directeur le 24 déc. 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy William Sewell en tant que directeur le 24 déc. 2024

    1 pagesTM01

    Modification des détails de Ga Minor Lp Investor Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 mars 2023

    2 pagesPSC05

    Cessation de Cromwell Capital Ventures Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 août 2024

    1 pagesPSC07

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 13 juin 2023

    LRESSP

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy William Sewell le 10 mai 2023

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Cromwell Director Limited le 10 mai 2023

    1 pagesCH02

    Modification des détails de Ga Minor Lp Investor Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 mai 2023

    2 pagesPSC05

    Modification des détails de Cromwell Capital Ventures Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 mai 2023

    2 pagesPSC05

    État du capital après une attribution d'actions au 09 mars 2023

    • Capital: EUR 213,147,710
    4 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 09 mars 2023

    • Capital: EUR 105,238,755
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Authorised share capital be increased, that this resolution constitutes the prior written consent to issue shares 28/02/2023
    RES13
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Statuts

    27 pagesMA

    Déclaration de confirmation établie le 07 janv. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2021

    16 pagesAA

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROWN, John Kenneth
    44 Beech Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QP Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    44 Beech Avenue
    Newton Mearns
    G77 5QP Glasgow
    Lanarkshire
    British111592160001
    MCCALL, Peter Michael
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    British119269620001
    CROMWELL CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    Cromwell Property Group
    United Kingdom
    Secrétaire
    Spaces, Lochrin Square, 1 Lochrin Square
    92-98 Fountainbridge
    EH3 9QA Edinburgh
    Cromwell Property Group
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrementSC219311
    133355520004
    DALGLEN SECRETARIES LIMITED
    Dalmore House
    310 St Vincent Street
    G2 5QR Glasgow
    Strathclyde
    Secrétaire désigné
    Dalmore House
    310 St Vincent Street
    G2 5QR Glasgow
    Strathclyde
    900015270001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Administrateur
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    BROOK, Robert William Middleton
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    Administrateur
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    United KingdomBritish59050120004
    CARRINGTON, Mark James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish162638140001
    CORSTORPHINE, Iain Anderson
    8 Willow Tree Place
    EH14 5AZ Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    8 Willow Tree Place
    EH14 5AZ Balerno
    Midlothian
    British105798020001
    COTTERELL, Robert James
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish172401090002
    DARLING, Andrew David
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    4 Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    West Lothian
    British73218540001
    GERVASI, Pierre Rene
    16 Rue Suzanne
    95600 Eaubonne
    95600
    France
    Administrateur
    16 Rue Suzanne
    95600 Eaubonne
    95600
    France
    French109596850001
    KENNEDY, Johann
    46 Cammo Gardens
    EH4 8EG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    46 Cammo Gardens
    EH4 8EG Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish119260990001
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Administrateur
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritish71043680001
    LANEFELT, Stefan Johan
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    SwedenSwedish158909670001
    LELEU, Thierry Hubert Francois
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomFrench178701910001
    MCCABE, Gary John
    Cleuch Avenue
    EH23 4RP North Middleton
    6
    Midlothian
    Administrateur
    Cleuch Avenue
    EH23 4RP North Middleton
    6
    Midlothian
    ScotlandBritish139525550001
    MCCABE, Gary John
    Deutschherrnufer 45
    Frankfurt Am Main
    60594
    Germany
    Administrateur
    Deutschherrnufer 45
    Frankfurt Am Main
    60594
    Germany
    British133465930001
    MCCARTHY, Martyn James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomAustralian126149680033
    MCDONALD, Derek
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    Administrateur
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    ScotlandBritish190466700001
    MORE, Gordon Lennie Truman
    Paseo De Peru 51 Cuidalcampo
    28707 Madrid
    Spain
    Administrateur
    Paseo De Peru 51 Cuidalcampo
    28707 Madrid
    Spain
    British111414890001
    PETTIT, Andrew John
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    Administrateur
    Balderton Street
    W1K 6TL London
    20
    EnglandBritish62947400004
    SEWELL, Timothy William
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    Administrateur
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    United KingdomBritish154627410001
    SHIELS, Paul
    60311 Frankfurt Am Main
    Frankfurt
    Goetheplatz 4
    Germany
    Administrateur
    60311 Frankfurt Am Main
    Frankfurt
    Goetheplatz 4
    Germany
    GermanyBritish136088930001
    SIME, Fraser Mckenzie
    Wilton Road
    EH16 5NN Edinburgh
    29
    Midlothian
    Administrateur
    Wilton Road
    EH16 5NN Edinburgh
    29
    Midlothian
    United KingdomBritish200848420001
    CROMWELL DIRECTOR LIMITED
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    Administrateur
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement5307786
    102622300003
    DALGLEN DIRECTORS LIMITED
    Dalmore House
    310 St Vincent Street
    G2 5QR Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur désigné
    Dalmore House
    310 St Vincent Street
    G2 5QR Glasgow
    Strathclyde
    900015260001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Cromwell Capital Ventures Uk Limited
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    06 avr. 2016
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement4329031
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Ga Minor Lp Investor Limited
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    06 avr. 2016
    Minerva House
    29 East Parade
    LS1 5PS Leeds
    5th Floor
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement8151647
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Share pledge agreement
    Créé le 06 nov. 2008
    Livré le 12 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First-ranking pledge over the pledged assets.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 nov. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 août 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge
    Créé le 06 août 2007
    Livré le 24 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The pledgors irrevocably and unconditionally grant a continuing first ranking pledge and security interest in favour of the pledgee over the pledged assets for the payment and discharge of all the secured obligations and the pledgee accepts the pledge. The pledge shall also cover any future extension of the secured obligations.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 août 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 août 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge
    Créé le 14 juin 2007
    Livré le 28 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The pledgors irrevocably and unconditionally grant a continuing first-ranking pledge and security interest in favour of the pledgee over the pledged assets for the payment and discharge of all the secured obligations and the pledgee accepts the pledge. The pledge shall also cover any future extension of the secured obligations.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 juin 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 août 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge agreement
    Créé le 03 avr. 2007
    Livré le 16 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The shares and related rights.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 avr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 août 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 16 mars 2007
    Livré le 22 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 mars 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 août 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Amendment agreement to the pledge agreement
    Créé le 20 déc. 2006
    Livré le 08 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The pledged assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 janv. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 août 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge agreement
    Créé le 12 juil. 2006
    Livré le 01 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The pledgor irrevocably and unconditionally grants a continuing first-ranking pledge and security interest in favour of the pledge over the pledged assets for the payment and discharge of all the secured obligations and the pledgee accepts the pledge - see form 410.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 août 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 août 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share pledge agreement
    Créé le 04 nov. 2005
    Livré le 14 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The shares and related assets.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transactions
    • 14 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 août 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 04 nov. 2005
    Livré le 08 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 août 2022Satisfaction d'une charge (MR04)

    EUROPEAN COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 juin 2023Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0