GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC292695 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
O ù se situe GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Addleshaw Goddard Llp Exchange Tower 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché) | 7 pages | LIQ13(Scot) | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Laura Harradine-Greene en tant que secrétaire le 07 mai 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 déc. 2018 | 27 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Justin Matthew King en tant que directeur le 04 mars 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 13 Queen's Road Aberdeen AB15 4YL à C/O Addleshaw Goddard Llp Exchange Tower 19 Canning Street Edinburgh EH3 8EH le 17 déc. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Anthony Gerald Jones en tant que directeur le 06 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 06 nov. 2019
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 oct. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge SC2926950010 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge SC2926950012 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge SC2926950009 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge SC2926950011 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 29 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Mr Richard Maclachlan en tant qu'administrateur le 01 févr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Roger Mclaughlan en tant que directeur le 01 févr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Justin Matthew King en tant qu'administrateur le 01 nov. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 oct. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Laura Harradine-Greene en tant que secrétaire le 01 févr. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Mary Elizabeth Bourlet en tant que secrétaire le 01 févr. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 03 nov. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACLACHLAN, Richard John | Administrateur | Exchange Tower 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh C/O Addleshaw Goddard Llp Scotland | England | British | 255019700001 | |||||
| BOURLET, Mary Elizabeth | Secrétaire | Syon Park, London Road Brentford TW8 8JF Middlesex Wyevale Garden Centres England | 213121340002 | |||||||
| HAMILTON, Kirsty Elizabeth | Secrétaire | 23 Speyburn Place Lawthorn KA11 2BE Irvine Ayrshire | British | 127615890001 | ||||||
| HARRADINE-GREENE, Laura | Secrétaire | Exchange Tower 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh C/O Addleshaw Goddard Llp Scotland | 242726430001 | |||||||
| JENKINSON, Antonia Scarlett | Secrétaire | 8 Stanmore Beedon RG20 8SR Newbury Berkshire | British | 72128340003 | ||||||
| SEALES, Sharon | Secrétaire | 22 Earlswood Wynd Montgomerie Park KA11 2FF Irvine Ayrshire | British | 106673560001 | ||||||
| STEINMEYER, Nils Olin | Secrétaire | Queen's Road AB15 4YL Aberdeen 13 United Kingdom | 173148570001 | |||||||
| WARD, Elizabeth Ann | Secrétaire | Queen's Road AB15 4YL Aberdeen 13 | 205482880001 | |||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secrétaire désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| BRADSHAW, Kevin Michael | Administrateur | Queen's Road AB15 4YL Aberdeen 13 | England | British | 124019940001 | |||||
| DAVIDSON, Paul Richmond | Administrateur | Alloway Cottage 4 Doonholm Road KA7 4QQ Alloway Ayrshire | United Kingdom | British | 114537830001 | |||||
| GATELEY, Donald Kenneth | Administrateur | 18 Clayhills Grove EH14 7NE Balerno Midlothian | United Kingdom | British | 104442220001 | |||||
| HUSTAD, Hans Kristian | Administrateur | Nygaards Alle 5, FOREIGN Oslo 0871 Norway | Norwegian | 103594230001 | ||||||
| JENKINSON, Antonia Scarlett | Administrateur | 8 Stanmore Beedon RG20 8SR Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 72128340003 | |||||
| JONES, Anthony Gerald | Administrateur | Queen's Road AB15 4YL Aberdeen 13 | England | British | 212265950002 | |||||
| KING, Justin Matthew | Administrateur | Exchange Tower 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh C/O Addleshaw Goddard Llp Scotland | England | British | 254876200001 | |||||
| KING, Justin Matthew | Administrateur | Syon Park, London Road Brentford TW8 8JF Middlesex Wyevale Garden Centres England | United Kingdom | British | 213157990001 | |||||
| KOZLOWSKI, Richard Leon | Administrateur | 34 Stubbs Wood HP6 6EX Amersham Buckinghamshire | England | British | 124967710001 | |||||
| LESLAU, Nicholas Mark | Administrateur | 48a Upper Brook Street W1K 2BT London | United Kingdom | British | 6815470015 | |||||
| MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Administrateur | Glan Honddu House Llandefaelog Fach LD3 9PP Brecon Powys | Wales | British | 1470180001 | |||||
| MCLAUGHLAN, Roger | Administrateur | Queen's Road AB15 4YL Aberdeen 13 | England | British | 208653010001 | |||||
| MCMAHON, James Cairns | Administrateur | Greenacres Kerrix Road KA1 5QP Symington Ayrshire | Scotland | British | 159708270001 | |||||
| MURPHY, Stephen Thomas | Administrateur | Queen's Road AB15 4YL Aberdeen 13 United Kingdom | England | British | 162853840001 | |||||
| PIERPOINT, David Julian | Administrateur | 33 West Street RH7 6QP Dormsland Rockvale Surrey | England | British | 138653690001 | |||||
| PITCHER, Stephen John | Administrateur | Queen's Road AB15 4YL Aberdeen 13 United Kingdom | United Kingdom | British | 138172490001 | |||||
| ROBERTSON, Lorraine Anne | Administrateur | St. Leonards Forest RH13 6PH Horsham Boundary Cottage West Sussex | England | British | 138172640001 | |||||
| STEINMEYER, Nils Olin | Administrateur | Queen's Road AB15 4YL Aberdeen 13 | United Kingdom | German | 126422100002 | |||||
| JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Administrateur désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Garden Centre Group Limited | 06 avr. 2016 | Queens Road AB15 4YL Aberdeen 13 Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 20 sept. 2017 Livré le 02 oct. 2017 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All current and future material property and material intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the debenture registered by this form MR01 (the "debenture"). For more details please refer to the debenture. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 20 sept. 2017 Livré le 29 sept. 2017 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 20 sept. 2017 Livré le 27 sept. 2017 | Totalement satisfaite | ||
Brève description N/A. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 20 sept. 2017 Livré le 26 sept. 2017 | Totalement satisfaite | ||
Brève description None. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security accession deed | Créé le 24 avr. 2012 Livré le 03 mai 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 24 avr. 2012 Livré le 03 mai 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security agreement | Créé le 24 févr. 2009 Livré le 04 mars 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 24 févr. 2009 Livré le 04 mars 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Supplemental charge | Créé le 12 févr. 2007 Livré le 01 mars 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The supplemental chargor with full title guarantee and as a continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities, has assigned, in favour of the security agent all its rights title and interest in and to the loan agreement and the borrower security documents. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 20 avr. 2006 Livré le 04 mai 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed charges over land and other assets (see paper apart 2 for details)including assignment and floating charge. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 20 avr. 2006 Livré le 04 mai 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 27 févr. 2006 Livré le 08 mars 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
GARDEN CENTRE HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0