INGEN HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | INGEN HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | SC292720 |
Juridiction | Écosse |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INGEN HOLDINGS LIMITED ?
Adresse du siège social | Annan House Palmerston Road AB11 5QP Aberdeen Scotland |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INGEN HOLDINGS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2023 |
Quels sont les derniers dépôts pour INGEN HOLDINGS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2023 | 17 pages | AA | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
État du capital au 15 déc. 2023
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 nov. 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Miss Latoya Scott en tant que secrétaire le 27 juin 2023 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Victor Jibuike en tant que secrétaire le 27 juin 2023 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Daniel Gary Mcateer en tant que directeur le 01 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022 | 12 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Wynterbee Robey le 04 mai 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr. Daniel Gary Mcateer en tant qu'administrateur le 04 mai 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr. Christopher Wynterbee Robey en tant qu'administrateur le 04 mai 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Ms Patricia Murray en tant qu'administrateur le 04 mai 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Nicola Dawn Mason en tant que directeur le 04 mai 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de James Lenton en tant que directeur le 04 mai 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de Afw Uk Oil & Gas Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 mars 2022 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021 | 12 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020 | 11 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Francis Honan en tant que directeur le 26 avr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de INGEN HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOTT, Latoya | Secrétaire | Great West Road TW8 9BW Brentford 27 England | 310642280001 | |||||||
MURRAY, Patricia | Administrateur | Palmerston Road AB11 5QP Aberdeen Annan House Scotland | United Kingdom | British | Finance Director | 276690010001 | ||||
POLL, Shaun | Administrateur | Palmerston Road AB11 5QP Aberdeen Annan House Scotland | England | British | Chartered Mechanical Engineer | 248598520001 | ||||
WYNTERBEE-ROBEY, Christopher | Administrateur | Palmerston Road AB11 5QP Aberdeen Annan House Scotland | England | British | Director Legal Services | 155779480001 | ||||
JIBUIKE, Victor | Secrétaire | Great West Road Brentford 27 United Kingdom | 239703120001 | |||||||
LEASK, Robert Alexander | Secrétaire | 5 Seaward Place G41 1HH Glasgow Foster Wheeler House Scotland | British | Director | 901410005 | |||||
MORRELL, Helen | Secrétaire | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire England | 197314900002 | |||||||
WARBURTON, Jennifer Ann | Secrétaire | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | 226867630001 | |||||||
RAEBURN CHRISTIE CLARK & WALLACE | Secrétaire désigné | 12-16 Albyn Place AB10 1PS Aberdeen | 900018800001 | |||||||
ASHTON, Robert Christopher | Administrateur | Great West Road TW8 9BW Brentford 27 England | United States | British | Director | 239701280001 | ||||
COLLIS, Mark Russell | Administrateur | 5 Seaward Place G41 1HH Glasgow Foster Wheeler House | United Kingdom | British | Accountant | 157584200007 | ||||
DUPAGNE, Laurent Jerome | Administrateur | Shinfield Park Shinfield RG2 9FW Reading Shinfield Park England | United Kingdom | French | Director | 98836590006 | ||||
EWENS, Andrew John | Administrateur | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire England | England | British | Director Of Operations | 123437990001 | ||||
FLEMING, Colin Ross | Administrateur | Palmerston Road AB11 5QP Aberdeen Annan House Scotland | Scotland | British | Finance Director | 72033550002 | ||||
GAYTON, Paul William | Administrateur | 5 Seaward Place G41 1HH Glasgow Foster Wheeler House Scotland | United Arab Emirates | British | Managing Director | 38211660003 | ||||
GORDON, Alan Stewart | Administrateur | Great West Road TW8 9BW Brentford 27 England | United Kingdom | British | Director | 181951380001 | ||||
HONAN, Thomas Francis | Administrateur | Great West Road TW8 9BW Brentford 27 England | Australia | Australian | Chief Financial Officer | 203162150001 | ||||
JOHNSTONE, Alan James | Administrateur | Palmerston Road AB11 5QP Aberdeen Annan House Scotland | Scotland | British | Managing Director | 108475490001 | ||||
LEASK, Robert Alexander | Administrateur | 12-16 Albyn Place Aberdeen AB10 1PS | Scotland | British | Director | 901410005 | ||||
LENTON, James Arnold | Administrateur | Great West Road Brentford 27 United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 209684910001 | ||||
MACKAY, Frazer Stuart | Administrateur | Shinfield Park Shinfield RG2 9FW Reading Shinfield Park England | Scotland | British | Director | 173700810001 | ||||
MASON, Nicola Dawn | Administrateur | Palmerston Road AB11 5QP Aberdeen Annan House Scotland | England | British | Operations Director | 252260430001 | ||||
MCATEER, Daniel Gary, Mr. | Administrateur | Palmerston Road AB11 5QP Aberdeen Annan House Scotland | Scotland | British | Vp Aberdeen Operation | 295688050001 | ||||
ROBERTSON, Andrew Laurence | Administrateur | 12-16 Albyn Place Aberdeen AB10 1PS | United Kingdom | British | Director | 47141930003 | ||||
ROSE, David Andrew | Administrateur | Shinfield Park Shinfield RG2 9FW Reading Shinfield Park England | United Kingdom | British | Director | 173702660001 | ||||
SHANAGHEY, Craig | Administrateur | Palmerston Road AB11 5QP Aberdeen Annan House Scotland | Scotland | British | Managing Director | 214430780001 | ||||
SLEIGH, Graham Bruce | Administrateur | Palmerston Road AB11 5QP Aberdeen Annan House Scotland | Scotland | British | Commercial Director | 195308100001 | ||||
STIRLING, Matthew James | Administrateur | Great West Road TW8 9BW Brentford 27 England | United Kingdom | British | Finance Director | 193093310001 | ||||
STRACHAN, Wayne Wishart Fraser | Administrateur | 12-16 Albyn Place Aberdeen AB10 1PS | Scotland | British | Director | 110972450005 | ||||
RAEBURN CHRISTIE TRUSTEES LIMITED | Administrateur | 12-16 Albyn Place AB10 1PS Aberdeen | 106814350001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INGEN HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afw Uk Oil & Gas Limited | 19 oct. 2017 | Palmerston Road AB11 5QP Aberdeen Annan House Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Worley Services Uk Limited | 19 oct. 2017 | Palmerston Road AB11 5QP Aberdeen Annan House Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Amec Foster Wheeler Group Limited | 30 août 2017 | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Amec Foster Wheeler (Holdings) Limited | 06 avr. 2016 | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0