LAST MILE INFRASTRUCTURE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | LAST MILE INFRASTRUCTURE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | SC293480 |
Juridiction | Écosse |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LAST MILE INFRASTRUCTURE LIMITED ?
Adresse du siège social | Fenick House Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Scotland Scotland |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LAST MILE INFRASTRUCTURE LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2025 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour LAST MILE INFRASTRUCTURE LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 nov. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 05 déc. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 nov. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour LAST MILE INFRASTRUCTURE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Lynne Marion Hainey le 18 juil. 2025 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
État du capital au 19 mars 2025
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2024 | 43 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Richard Dean le 07 juin 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Colin John Lynch en tant que directeur le 15 mai 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge SC2934800019 | 1 pages | MR05 | ||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2023 | 42 pages | AA | ||||||||||||||
Détails de la variation des droits attachés aux actions | 2 pages | SH10 | ||||||||||||||
Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions | 2 pages | SH08 | ||||||||||||||
Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 21 nov. 2022 | 3 pages | RP04CS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 nov. 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Inscription de la charge SC2934800020, créée le 01 sept. 2023 | 19 pages | MR01 | ||||||||||||||
Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge SC2934800017 | 1 pages | MR05 | ||||||||||||||
Nomination de Mr David Matthew Begley en tant qu'administrateur le 10 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Deuxième dépôt d'un bilan du capital suite à une émission d'actions au 08 févr. 2023
| 4 pages | RP04SH01 | ||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 08 févr. 2023
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Mr Michael Howard Davies en tant que secrétaire le 01 févr. 2023 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Kirsty Jane Nellany en tant que secrétaire le 01 févr. 2023 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 nov. 2022 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Mr Colin John Lynch en tant qu'administrateur le 01 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Craig Martin Boath en tant qu'administrateur le 01 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de LAST MILE INFRASTRUCTURE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVIES, Michael Howard | Secrétaire | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | 305166880001 | |||||||
BEGLEY, David Matthew | Administrateur | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | Scotland | British | Director | 291287140001 | ||||
BOATH, Craig Martin | Administrateur | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | Scotland | British | Managing Director | 121727870002 | ||||
DEAN, John Richard | Administrateur | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | Scotland | British | Associate Director | 248710960002 | ||||
HAINEY, Lynne Marion | Administrateur | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | Scotland | British | Chartered Accountant | 261642240002 | ||||
NELLANY, Kirsty Jane | Administrateur | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | Scotland | British | Chief Operating Officer | 291236840001 | ||||
ALCOCK, Nigel John | Secrétaire | Stanley Boulevard Hamilton International Technology Park G72 0BN Glasgow International House South Lanarkshire | 196581610001 | |||||||
NELLANY, Kirsty Jane | Secrétaire | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | 298051310001 | |||||||
NELLANY, Kirsty Jane | Secrétaire | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | 261642260001 | |||||||
ROBERTSON, Robert Murray | Secrétaire | 19 Newark Drive Pollokshields G41 4QB Glasgow | British | Chartered Accountants | 116638960001 | |||||
SCOTT, Mark Wilburn | Secrétaire | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | 291286840001 | |||||||
BRIAN REID LTD. | Secrétaire désigné | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park Logie Green Road EH7 4HH Edinburgh | 900018660001 | |||||||
ALCOCK, Nigel John | Administrateur | Stanley Boulevard Hamilton International Technology Park G72 0BN Glasgow International House South Lanarkshire Scotland | England | British | Chief Financial Officer | 131688950002 | ||||
CITRIN, David Lewis Robert | Administrateur | 161 Terregles Avenue Pollokshields G41 4RT Glasgow | Uk | British | Director | 47150010002 | ||||
GREEN, Andrew Richard | Administrateur | Stanley Boulevard Hamilton International Technology Park G72 0BN Glasgow International House South Lanarkshire | England | British | Director | 164140690001 | ||||
HOWARD, Jonathan Paul | Administrateur | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | Wales | British | Director | 228310160001 | ||||
LYNCH, Colin John | Administrateur | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | Scotland | British | Managing Director | 269661250001 | ||||
MCCALL, Graham Kenneth | Administrateur | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 109694640002 | ||||
MCCLYMONT, William Glendinning | Administrateur | Stanley Boulevard Hamilton International Technology Park G72 0BN Glasgow International House South Lanarkshire | United Kingdom | British | Director | 81054750002 | ||||
MILLER, Amanda | Administrateur | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | United Kingdom | Scottish | Hr Director | 228852900001 | ||||
MORRIS, Stephen James | Administrateur | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | United Kingdom | British | Director | 129509170001 | ||||
O'DONNELL, Harry Joseph | Administrateur | 60 Newark Drive Pollokshields G41 4PX Glasgow | Scotland | British | Director | 46524710002 | ||||
PEARCE, Michael William | Administrateur | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland Scotland | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 77521670011 | ||||
ROBERTSON, Robert Murray | Administrateur | 19 Newark Drive Pollokshields G41 4QB Glasgow | Scotland | British | Chartered Accountants | 116638960001 | ||||
STEWART, Kenneth | Administrateur | 1 Barrachnie Grove Garrowhill G69 6SS Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Company Director | 121285420001 | ||||
STEPHEN MABBOTT LTD. | Administrateur désigné | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | 900018650001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LAST MILE INFRASTRUCTURE LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallus Nominees Limited | 14 janv. 2019 | 5 Appold Street EC2A 2DA London Broadwalk House United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Macquarie European Investment Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 28 Ropemaker Street EC2Y 9HD London Ropemaker Place England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Last Mile Infrastructure Holdco Limited | 06 avr. 2016 | Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Fenick House Scotland United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0