TURNDEBTAROUND LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTURNDEBTAROUND LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC296390
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TURNDEBTAROUND LTD ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe TURNDEBTAROUND LTD ?

    Adresse du siège social
    8 Albany Street
    Hudson House Business Centre
    EH1 3QB Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TURNDEBTAROUND LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NEWTOMORROW LIMITED31 janv. 200631 janv. 2006

    Quels sont les derniers comptes de TURNDEBTAROUND LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour TURNDEBTAROUND LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019

    11 pagesAA

    Cessation de la nomination de Daniel Thomas Slater Walker en tant que directeur le 09 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 4 Queen Street Suite 1 Edinburgh EH2 1JE Scotland à 8 Albany Street Hudson House Business Centre Edinburgh EH1 3QB le 08 févr. 2019

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Porterfield Financial Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 déc. 2017

    2 pagesPSC02

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017

    10 pagesAA

    legacy

    2 pagesGUARANTEE2

    Satisfaction de la charge SC2963900003 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge SC2963900004, créée le 05 déc. 2017

    15 pagesMR01

    Satisfaction de la charge SC2963900002 en totalité

    1 pagesMR04

    Changement d'adresse du siège social de Gf - 6 Deer Park Avenue Fairways Business Park Livingston West Lothian EH54 8AF Scotland à 4 Queen Street Suite 1 Edinburgh EH2 1JE le 16 oct. 2017

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr David Andrew Gray en tant qu'administrateur le 11 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Morton Fraser Secretaries Limited en tant que secrétaire le 22 sept. 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Thomas Martin Jones en tant qu'administrateur le 11 août 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de Invocas Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 août 2017

    1 pagesPSC07

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de David Ewing en tant que directeur le 31 janv. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Morton Fraser Secretaries Limited en tant que secrétaire le 09 déc. 2016

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Julie-Anne Afrin en tant que directeur le 09 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Julie-Anne Afrin en tant que secrétaire le 09 déc. 2016

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de TURNDEBTAROUND LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GRAY, David Andrew
    Albany Street
    Hudson House Business Centre
    EH1 3QB Edinburgh
    8
    Scotland
    Administrateur
    Albany Street
    Hudson House Business Centre
    EH1 3QB Edinburgh
    8
    Scotland
    United KingdomBritish156334330001
    JONES, Thomas Martin
    Albany Street
    Hudson House Business Centre
    EH1 3QB Edinburgh
    8
    Scotland
    Administrateur
    Albany Street
    Hudson House Business Centre
    EH1 3QB Edinburgh
    8
    Scotland
    EnglandBritish137147240002
    AFRIN, Julie-Anne
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    Secrétaire
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    178000700001
    DRUMMOND, Robert Lindsay
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    Secrétaire
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    British136151950001
    HALL, John Michael
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    Secrétaire
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    British167366960001
    LIGHTLEY, Stephen John
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Secrétaire
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British47296680002
    PARSLIFFE, Andrew John
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    Secrétaire
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    British169956040001
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Secrétaire désigné
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor, Quartermile Two
    Scotland
    Secrétaire
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor, Quartermile Two
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC262093
    95512800001
    AFRIN, Julie-Anne
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish132606040001
    BELL, Howard James
    The Manor House
    Nesfield
    LS29 0BN Ilkley
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Manor House
    Nesfield
    LS29 0BN Ilkley
    North Yorkshire
    British8909130003
    CARTWRIGHT, Bentley Norman
    Waterloo Bank
    EH26 8NS Penicuik
    16
    Midlothian
    Administrateur
    Waterloo Bank
    EH26 8NS Penicuik
    16
    Midlothian
    United KingdomBritish129918710001
    DINOLFI, Amerigo
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish105243090001
    DRUMMOND, Robert Lindsay
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    Administrateur
    Braehead Avenue
    Milngavie
    G62 6DY Glasgow
    56
    ScotlandBritish136151950001
    EWING, David
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    Deer Park Avenue
    Fairways Business Park
    EH54 8AF Livingston
    Gf - 6
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish86695980003
    FERGUSON, Brian
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    Administrateur
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    ScotlandBritish154774310001
    HALL, John Michael
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    Administrateur
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Uk
    ScotlandBritish107926760002
    HALL, John Michael
    31 Lauder Road
    EH9 2JG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    31 Lauder Road
    EH9 2JG Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish107926760002
    LEWIS, Peter Cyril Robert
    Abbey House Moorland Road
    Bramhope
    LS16 9HW Leeds
    Administrateur
    Abbey House Moorland Road
    Bramhope
    LS16 9HW Leeds
    EnglandBritish56467830001
    LIGHTLEY, Stephen John
    Graham Park Road
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    36
    England
    Administrateur
    Graham Park Road
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    36
    England
    United KingdomBritish47296680002
    LIGHTLEY, Stephen John
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Administrateur
    36 Graham Park Road
    Gosforth
    NE3 4BJ Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish47296680002
    MACMILLAN, David Roy
    Gosford Road
    Longniddry
    EH32 0LF East Lothian
    Martinknowe
    Administrateur
    Gosford Road
    Longniddry
    EH32 0LF East Lothian
    Martinknowe
    ScotlandBritish175002230001
    PARSLIFFE, Andrew John
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish67033440002
    REYNOLDS, Caroline Michelle
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    98 West George Street
    G2 1PJ Glasgow
    James Miller House
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish176061270001
    WALKER, Daniel Thomas Slater
    Albany Street
    Hudson House Business Centre
    EH1 3QB Edinburgh
    8
    Scotland
    Administrateur
    Albany Street
    Hudson House Business Centre
    EH1 3QB Edinburgh
    8
    Scotland
    EnglandBritish159962640001
    WRIGHT, Ian William
    Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    5
    Administrateur
    Kirklee Circus
    G12 0TW Glasgow
    5
    ScotlandBritish111353760002
    WRIGHT, Rachel Jane Simpson
    Kirklee Circus
    Kelvinside
    G12 0TW Glasgow
    5
    Administrateur
    Kirklee Circus
    Kelvinside
    G12 0TW Glasgow
    5
    ScotlandBritish129920750001
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Administrateur désigné
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TURNDEBTAROUND LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    West Dock Street
    HU3 4HH Hull
    West 1 Business Centre
    England
    12 déc. 2017
    West Dock Street
    HU3 4HH Hull
    West 1 Business Centre
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement10902667
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Invocas Group Plc
    Fairways Business Park, Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    Gf 6
    Scotland
    14 janv. 2017
    Fairways Business Park, Deer Park Avenue
    EH54 8AF Livingston
    Gf 6
    Scotland
    Oui
    Forme juridiquePlc
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006 Uk
    Lieu d'enregistrementScotland
    Numéro d'enregistrementSc295886
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TURNDEBTAROUND LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 05 déc. 2017
    Livré le 08 déc. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kpi (Nominees) Limited
    Transactions
    • 08 déc. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 26 mai 2016
    Livré le 07 juin 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kpi (Nominees) Limited
    Transactions
    • 07 juin 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 juin 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 30 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 28 janv. 2016
    Livré le 05 févr. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 févr. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 juin 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 02 oct. 2006
    Livré le 13 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 nov. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0