CALA PROPERTIES (BRANDON) LIMITED

CALA PROPERTIES (BRANDON) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCALA PROPERTIES (BRANDON) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC297555
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CALA PROPERTIES (BRANDON) LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CALA PROPERTIES (BRANDON) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CALA PROPERTIES (BRANDON) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CIS (MOTHERWELL) LIMITED23 mai 200623 mai 2006
    TM 1251 LIMITED22 févr. 200622 févr. 2006

    Quels sont les derniers comptes de CALA PROPERTIES (BRANDON) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour CALA PROPERTIES (BRANDON) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    8 pages4.26(Scot)

    Cessation de la nomination de John Graham Gunn Reid en tant que directeur le 07 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan Duke Brown en tant que directeur le 07 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 11 mars 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 févr. 2015

    État du capital au 26 févr. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 févr. 2014

    État du capital au 24 févr. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2012

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2011

    15 pagesAA

    Cessation de la nomination de Gerald Campbell More en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG03s

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2010

    15 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alasdair Murray Macconnell en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    10 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    Comptes annuels établis au 30 juin 2009

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Alastair John Harley Hepburn en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de CALA PROPERTIES (BRANDON) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEDGE SERVICES LIMITED
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Secrétaire
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    42504200004
    LEES, Moira Ann
    389 Bury Road
    Edgworth
    BL7 0BU Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    389 Bury Road
    Edgworth
    BL7 0BU Bolton
    Lancashire
    British34646780001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003420001
    BROPHY, John Francis
    St Ronans Terrace
    Innerleithen
    EH44 6RB Tweeddale
    38
    Administrateur
    St Ronans Terrace
    Innerleithen
    EH44 6RB Tweeddale
    38
    United KingdomBritish133189190001
    BROWN, Alan Duke
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Administrateur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    EnglandBritish32640750005
    DEVINE, Paul John
    Little Garth 33 Marmion Road
    EH39 4PF North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Little Garth 33 Marmion Road
    EH39 4PF North Berwick
    East Lothian
    British43368870002
    FRANKS, John
    Pool Meadow
    South Park Drive
    SK12 1BS Poynton
    Cheshire
    Administrateur
    Pool Meadow
    South Park Drive
    SK12 1BS Poynton
    Cheshire
    United KingdomBritish63264700002
    HEPBURN, Alastair John Harley
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Administrateur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    UkBritish114477450002
    JONES, Ian Michael
    37 Rosemary Drive
    WA12 0BQ Newton Le Willows
    Merseyside
    Administrateur
    37 Rosemary Drive
    WA12 0BQ Newton Le Willows
    Merseyside
    United KingdomBritish43978180001
    MACCONNELL, Alasdair Murray
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Administrateur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish54405740002
    MORE, Gerry Campbell
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Administrateur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish177944940001
    REID, John Graham Gunn
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Administrateur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    ScotlandBritish54537790003
    SHARMAN, Paul
    Ridgelands Farm
    Ridgelands Lane, Newick
    BN8 4RR Lewes
    East Sussex
    Administrateur
    Ridgelands Farm
    Ridgelands Lane, Newick
    BN8 4RR Lewes
    East Sussex
    United KingdomBritish105319100001
    REYNARD NOMINEES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900011050001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003410001

    CALA PROPERTIES (BRANDON) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of confirmation
    Créé le 21 déc. 2009
    Livré le 24 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 24 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 16 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 13 févr. 2007
    Livré le 17 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Three seperate areas of land in motherwell town centre in the county of lanark extending to five hundred and forty six square metres (546 square metres) or thereby and five hectares and thirty nine decimal or one hundredth parts of a hectare (5.39 hectares) or thereby and one hectare and ninety six decimal or one hundredth parts of a hectare (1.96 hectares) or thereby LAN190508.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 févr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Assignation of rents
    Créé le 09 févr. 2007
    Livré le 13 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rental income over subjects at the brandon centre, motherwell.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 févr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Floating charge
    Créé le 08 févr. 2007
    Livré le 19 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 févr. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 févr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 08 févr. 2007
    Livré le 19 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 19 févr. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 févr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 08 févr. 2007
    Livré le 19 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Uberior Ventures Limited
    Transactions
    • 19 févr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 févr. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    CALA PROPERTIES (BRANDON) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 mars 2015Commencement of winding up
    30 juin 2017Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0