SPARK ENERGY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSPARK ENERGY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC301188
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SPARK ENERGY LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques
    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe SPARK ENERGY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Grampian House
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SPARK ENERGY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MBM SHELFCO (17) LIMITED24 avr. 200624 avr. 2006

    Quels sont les derniers comptes de SPARK ENERGY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour SPARK ENERGY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 28 oct. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge SC3011880018 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC3011880015 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC3011880016 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC3011880019 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC3011880017 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2020

    39 pagesAA

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Cessation de la nomination de Adrian James Letts en tant que directeur le 01 mars 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de William Thomas Castell en tant que directeur le 10 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 28 oct. 2021 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    legacy

    90 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2019

    33 pagesAA

    legacy

    78 pagesPARENT_ACC

    Nomination de Mr William Thomas Castell en tant qu'administrateur le 18 janv. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen James Fitzpatrick en tant que directeur le 18 janv. 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Raman Bhatia en tant qu'administrateur le 18 janv. 2021

    2 pagesAP01

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Cessation de la nomination de Hamish Duncan Adam Osborn en tant que directeur le 12 janv. 2021

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Ettrick Riverside Dunsdale Road Selkirk TD7 5EB United Kingdom à Grampian House 200 Dunkeld Road Perth PH1 3GH le 14 déc. 2020

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de SPARK ENERGY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BHATIA, Raman
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    Administrateur
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    EnglandBritish270583010001
    CASEY, Vincent Francis
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    Administrateur
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    EnglandBritish178791810001
    HARDING, Debbie Mary
    Dunsdale Road
    TD7 5EB Selkirk
    Ettrick Riverside
    United Kingdom
    Secrétaire
    Dunsdale Road
    TD7 5EB Selkirk
    Ettrick Riverside
    United Kingdom
    199027490001
    MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    133157900001
    CASTELL, William Thomas
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    Administrateur
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    EnglandBritish248424970001
    DARLING, Peter John
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    ScotlandBritish112278310003
    DARLING, Peter John
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    ScotlandBritish112278310003
    FITZPATRICK, Stephen James
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    Administrateur
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    EnglandBritish250455850001
    FLETCHER, Christopher George Alvan
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    ScotlandBritish37648250001
    GAULD, Chris
    Dunsdale Road
    TD7 5EB Selkirk
    Ettrick Riverside
    United Kingdom
    Administrateur
    Dunsdale Road
    TD7 5EB Selkirk
    Ettrick Riverside
    United Kingdom
    ScotlandBritish121215600005
    LEEMING, Nicholas John
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    United KingdomBritish152402490001
    LETTS, Adrian James
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    Administrateur
    200 Dunkeld Road
    PH1 3GH Perth
    Grampian House
    Scotland
    United KingdomBritish113080180005
    LYON, Kevin John
    Dunsdale Road
    TD7 5EB Selkirk
    Ettrick Riverside
    United Kingdom
    Administrateur
    Dunsdale Road
    TD7 5EB Selkirk
    Ettrick Riverside
    United Kingdom
    ScotlandBritish114851270001
    MUSTO, Adrian Arnold
    Floor
    7 Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    7 Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    EnglandBritish150471180001
    NOBLE, Timothy Peter, Sir
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    United KingdomBritish685750001
    OSBORN, Hamish Duncan Adam
    Dunsdale Road
    TD7 5EB Selkirk
    Ettrick Riverside
    United Kingdom
    Administrateur
    Dunsdale Road
    TD7 5EB Selkirk
    Ettrick Riverside
    United Kingdom
    ScotlandBritish155166850013
    PAGET, James Hedley
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    SwitzerlandBritish141767290002
    ROSA, Joao Vicente Goncalves
    Greycoat Place
    SW1P 1SB London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    Greycoat Place
    SW1P 1SB London
    2
    United Kingdom
    EnglandPortuguese166127180001
    TRIGG, Christopher Michael
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    ScotlandBritish95759190003
    MBM NOMINEES LIMITED
    107 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    107 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Midlothian
    106913730001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SPARK ENERGY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ovo Energy Ltd
    Rivergate
    Temple Quay
    BS1 6ED Bristol
    1
    United Kingdom
    28 nov. 2018
    Rivergate
    Temple Quay
    BS1 6ED Bristol
    1
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement06890795
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    25-27 Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    Warwick House
    England
    25 août 2016
    25-27 Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    Warwick House
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement10145862
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    SPARK ENERGY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 oct. 2020
    Livré le 19 oct. 2020
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transactions
    • 19 oct. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 oct. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 oct. 2020
    Livré le 05 oct. 2020
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Various trade marks registered in the name spark energy limited, including: "spark" bearing UK trademark number UK00003039260; "spark energy" bearing UK trademark number UK00002437457. For additional details please refer to schedule 5 of the security instrument and schedule 6 to the appended debenture dated 14 january 2020.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited (As Security Agent)
    Transactions
    • 05 oct. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 oct. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 06 août 2020
    Livré le 17 août 2020
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transactions
    • 17 août 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 oct. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 14 janv. 2020
    Livré le 30 janv. 2020
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited (As Security Agent)
    Transactions
    • 30 janv. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 oct. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 14 janv. 2020
    Livré le 20 janv. 2020
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Various trademarks registered in the name of spark energy limited including: "spark energy" bearing united kingdom trademark number UK00002437457; "spark" bearing united kingdom trademark number UK00003039260. For additional details please refer to schedule 6 of the security instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited (As Security Agent)
    Transactions
    • 20 janv. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 févr. 2020Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge (MR05)
    • 13 oct. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 janv. 2019
    Livré le 14 janv. 2019
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Shell Energy Europe Limited
    Transactions
    • 14 janv. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 02 mai 2017
    Livré le 17 mai 2017
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited, London Branch
    Transactions
    • 17 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 21 avr. 2017
    Livré le 02 mai 2017
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited, London Branch
    Transactions
    • 02 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 21 avr. 2017
    Livré le 02 mai 2017
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited, London Branch
    Transactions
    • 02 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 mai 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 mai 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 21 avr. 2017
    Livré le 02 mai 2017
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited, London Branch
    Transactions
    • 02 mai 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 28 avr. 2016
    Livré le 06 mai 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 mai 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 mai 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 janv. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 24 déc. 2015
    Livré le 11 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited
    Transactions
    • 11 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 24 déc. 2015
    Livré le 11 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited
    Transactions
    • 11 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 janv. 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 mai 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 mai 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 mai 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 24 déc. 2015
    Livré le 08 janv. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited
    Transactions
    • 08 janv. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 janv. 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 mai 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 26 nov. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 07 janv. 2014
    Livré le 09 janv. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Robert Douglas Millar
    • Richard Burns
    • Claire Fletcher
    • Sir Timothy Noble
    Transactions
    • 09 janv. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 janv. 2014Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 oct. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Plus de quatre personnes ayant droit Oui
    A registered charge
    Créé le 02 déc. 2013
    Livré le 12 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Morgan Stanley Capital Group Inc
    Transactions
    • 12 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 déc. 2013Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 janv. 2014Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 05 août 2011
    Livré le 10 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £915,000 due in terms of the loan agreements
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Sir Timothy Noble & Others
    Transactions
    • 10 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 10 août 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 déc. 2013Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 19 mai 2008
    Livré le 21 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Sebsed Limited
    Transactions
    • 21 mai 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 août 2008Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 août 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 juin 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 26 juil. 2007
    Livré le 14 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 juil. 2008Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 août 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 déc. 2013Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 janv. 2014Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0