MACROCOM (948) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMACROCOM (948) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC303436
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MACROCOM (948) LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe MACROCOM (948) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    272 Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MACROCOM (948) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour MACROCOM (948) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Nomination de Mr Jonathan Andrew Graham en tant qu'administrateur le 30 sept. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jonathan Barrie Morris en tant que directeur le 30 sept. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020

    1 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Paul Jenkins en tant qu'administrateur le 31 déc. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Derek George Usher en tant que directeur le 31 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Barrie Morris le 23 oct. 2020

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Jonathan Barrie Morris en tant qu'administrateur le 12 mai 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Craig Anthony Buick en tant que directeur le 12 mai 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Derek George Usher en tant qu'administrateur le 23 janv. 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kenneth John Stannard en tant que directeur le 31 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Charlotte Taggart en tant que secrétaire le 29 mars 2019

    1 pagesTM02

    Nomination de Sarah Whiteley en tant que secrétaire le 29 mars 2019

    2 pagesAP03

    legacy

    5 pagesRP04CS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    3 pagesAA

    legacy

    4 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    08 mars 2019Second Filing The information on the form CS01, Part 2 has been replaced by a second filing on 08/03/2019

    Notification de Apex Credit Management Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Qui sont les dirigeants de MACROCOM (948) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WHITELEY, Sarah
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    Secrétaire
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    256931970001
    GRAHAM, Jonathan Andrew
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    Administrateur
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    EnglandBritish79267560001
    JENKINS, Paul
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    Administrateur
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    EnglandBritish120733130002
    CARTWRIGHT, Peter Bramwell
    Bedford Street
    WC2E 9ES London
    25
    Secrétaire
    Bedford Street
    WC2E 9ES London
    25
    British169199100001
    FRASER, Paul Francis
    Ardgryfe Manor
    Craigends
    PA6 7BB Houston
    Renfrewshire
    Secrétaire
    Ardgryfe Manor
    Craigends
    PA6 7BB Houston
    Renfrewshire
    British63596150002
    MCCORMICK, Andrew Sawers
    31 Aytoun Road
    Pollokshields
    G41 5HW Glasgow
    Secrétaire
    31 Aytoun Road
    Pollokshields
    G41 5HW Glasgow
    British426100001
    RANDALL, John David
    2 Caird Park
    ML3 0EU Hamilton
    Mediacorp House
    South Lanarkshire
    Secrétaire
    2 Caird Park
    ML3 0EU Hamilton
    Mediacorp House
    South Lanarkshire
    171105410001
    TAGGART, Charlotte
    10-15 Queen Street
    EC4N 1TX London
    Aldermary House
    England
    England
    Secrétaire
    10-15 Queen Street
    EC4N 1TX London
    Aldermary House
    England
    England
    193781990001
    TELFORD, Juliet Sarah
    27 Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    27 Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House
    Warwickshire
    United Kingdom
    British64763740001
    WELLINGHOFF, Willem Pieter
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    Scotland
    Secrétaire
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    Scotland
    174966010001
    MACROBERTS - (FIRM)
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Secrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    900018030001
    BUICK, Craig Anthony
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    Administrateur
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    United KingdomBritish,Australian204155120001
    CARTWRIGHT, Peter Bramwell
    Elvet Lodge
    138b Beacon Hill Road
    NG24 2JJ Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Elvet Lodge
    138b Beacon Hill Road
    NG24 2JJ Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritish169199100001
    CLYNE, Neil
    27 Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    27 Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Apex House
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritish126151310001
    CRAWFORD, Glen Paul
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish160890830001
    FRASER, Paul Francis
    Ardgryfe Manor
    Craigends
    PA6 7BB Houston
    Renfrewshire
    Administrateur
    Ardgryfe Manor
    Craigends
    PA6 7BB Houston
    Renfrewshire
    United KingdomBritish63596150002
    MCCORMICK, Andrew Sawers
    31 Aytoun Road
    Pollokshields
    G41 5HW Glasgow
    Administrateur
    31 Aytoun Road
    Pollokshields
    G41 5HW Glasgow
    United KingdomBritish426100001
    MCMANUS, Douglas James
    25 Broadmeadow Lane
    CV37 9FD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    25 Broadmeadow Lane
    CV37 9FD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritish70302800003
    MORRIS, Jonathan Barrie
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    Administrateur
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    EnglandBritish262461330002
    MOUAT, Bryan
    8/1 Merchant City Tower
    4 Bell Street
    G1 1LG Glasgow
    Administrateur
    8/1 Merchant City Tower
    4 Bell Street
    G1 1LG Glasgow
    ScotlandBritish79587020007
    MOUND, Stephen Neil
    27a Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Stanford House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    27a Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Stanford House
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritish132057230001
    RANDALL, John David
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish160890600001
    ROSS-ROBERTS, Christopher Michael David
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritish170918350001
    SHARPE, Jacqueline
    2 Fourth Avenue
    Millerston
    G33 6LB Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    2 Fourth Avenue
    Millerston
    G33 6LB Glasgow
    Lanarkshire
    British120560320001
    SHEPPARD, Martin John
    Pentire
    Bishopton Lane
    CV37 9QY Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    Pentire
    Bishopton Lane
    CV37 9QY Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    UkBritish147289710001
    STANNARD, Kenneth John
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UA West Malling
    1
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish103402250002
    TELFORD, Juliet Sarah
    27a Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Stanford House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    27a Arden Street
    CV37 6NW Stratford-Upon-Avon
    Stanford House
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritish64763740001
    USHER, Derek George
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    Administrateur
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Scotland
    EnglandBritish194636730001
    WAITE, David
    40a Gladstone Grove
    SK4 4DA Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    40a Gladstone Grove
    SK4 4DA Stockport
    Cheshire
    British66788780001
    MACROBERTS CORPORATE SERVICES LIMITED
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Administrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    900018020001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MACROCOM (948) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Apex Credit Management Holdings Limited
    Buckingham Road
    NN13 7DN Brackley
    Dlc
    Northamptonshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Buckingham Road
    NN13 7DN Brackley
    Dlc
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement06424400
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0