THE PEARCE INSTITUTE
Vue d'ensemble
Nom de la société | THE PEARCE INSTITUTE |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
Numéro de société | SC310974 |
Juridiction | Écosse |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE PEARCE INSTITUTE ?
Adresse du siège social | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE PEARCE INSTITUTE ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2025 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE PEARCE INSTITUTE ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 24 oct. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 07 nov. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 24 oct. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour THE PEARCE INSTITUTE ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2024 | 17 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gary Philip Maguire le 25 sept. 2024 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023 | 17 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022 | 18 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Lesley Ann Mcgregor en tant que directeur le 30 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de James Allan Graeme Young en tant que directeur le 30 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2021 | 16 pages | AA | ||
Nomination de Deirdre Gaughan en tant qu'administrateur le 26 nov. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020 | 16 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Ian Alistair Macpherson en tant que directeur le 03 oct. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Thomas Mcinally en tant que directeur le 03 mars 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de James Patterson Allan en tant que directeur le 23 janv. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019 | 16 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mrs Lesley Ann Mcgregor en tant qu'administrateur le 16 août 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr David Paterson en tant qu'administrateur le 16 août 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Andrew Masterson en tant que directeur le 03 mai 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Paul Cormie Robertson Macalindin en tant que directeur le 02 mai 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Ms Vivienne Clare Sawers en tant qu'administrateur le 21 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Elizabeth Monica Mcalinden en tant qu'administrateur le 21 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de THE PEARCE INSTITUTE ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELL, Richard Joseph | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | Scottish | City Councillor | 251989890001 | ||||
CLARK, Esme Harrower | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Retired Bookseller | 152093770003 | ||||
DONALD, Elsie Wales Kelso | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Retired | 208195830001 | ||||
GAUGHAN, Deirdre | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | Scottish | Community Worker | 289052110001 | ||||
MAGUIRE, Gary Philip | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Cultural Services Manager | 180163710002 | ||||
MCALINDEN, Elizabeth Monica | Administrateur | 795 Govan Road Govan G51 3JW Glasgow Govan Cross Shopping Centre Scotland | Scotland | British | Property Manager | 257003380001 | ||||
PATERSON, David | Administrateur | Shieldburn Road G51 4HS Glasgow 60 Scotland | Scotland | British | Retired | 101064720001 | ||||
SAWERS, Vivienne Clare | Administrateur | 840-860 Govan Road G51 3UU Glasgow Pearce Institute Scotland | Scotland | Scottish | Chief Officer | 198936960001 | ||||
MACKIE, Norman Sinclair | Secrétaire | 54 Craigton Drive G77 6TD Glasgow | British | Chief Executive | 91489120001 | |||||
WHITE, Iain | Secrétaire | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | 182388420001 | |||||||
BURNESS LLP | Secrétaire | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh | 99448920001 | |||||||
ADAMS, James | Administrateur | - 860 Govan Road G51 3UU Glasgow 840 Scotland | Scotland | British | Councillor | 180238730001 | ||||
ALCADE, Borja | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | Spanish | Creative Director | 180163560001 | ||||
ALLAN, James Patterson | Administrateur | 840 - 860 Govan Road Renfrew G51 3UU Renfrew Pearce Engineer Renfrewshire United Kingdom | United Kingdom | British | Engineer | 176162200001 | ||||
CARABINE, Richard | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Retired | 18163890001 | ||||
CARABINE, Richard | Administrateur | Govan Road G51 3DJ Glasgow 813 Lanarkshire | Scotland | British | Retired | 18163890001 | ||||
CHALMERS, Patricia | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Director | 67620530001 | ||||
CHAPMAN, Roger | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Retired | 191482410001 | ||||
DOCHERTY, Thomas Andrew John | Administrateur | Courthill Avenue G44 5AA Glasgow 37 Lanarkshire | Scotland | British | Executive | 116432340001 | ||||
FENN, Owen Michael | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | Scottish | Project Manager | 239621050001 | ||||
FLANAGAN, John Gerard | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | Irish | Solicitor | 65882120001 | ||||
HAHN, Germaine Mary | Administrateur | Mckechnie Street G51 3AQ Glasgow 35 | Scotland | British | Director Of Govan Housing Assoc | 79871050001 | ||||
HAHN, Germaine Mary | Administrateur | 23 Dunglass Avenue G14 9ED Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Housing Association Executive | 79871050001 | ||||
KAUR, Amreeta Manjit | Administrateur | Garrioch Road Flat 0/1 G20 8RJ Glasgow 167 Scotland | Scotland | British | Company Director | 183378600001 | ||||
MACALINDIN, Paul Cormie Robertson | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Musician | 236105400001 | ||||
MACKAY, Murdo John Norman | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Minister Of Religion | 193055370001 | ||||
MACPHERSON, Ian Alistair | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Consultant | 32152170001 | ||||
MASTERSON, Andrew | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Headteacher | 188364430001 | ||||
MCGLYNN, Mary Elizabeth Moyna, Rev Dr | Administrateur | 796 Govan Road G51 2YL Glasgow Govan + Linthouse Church | Scotland | British | Church Minister | 148748580001 | ||||
MCGREGOR, Lesley Ann | Administrateur | Churchill Place Kilbarchan PA10 2EH Johnstone 5 Scotland | Scotland | British | Funding/Business Development | 242887120001 | ||||
MCINALLY, Thomas | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | Town Planner | 79280400001 | ||||
MOLLINS, Kenneth | Administrateur | Mckechnie Street Govan G51 3AQ Glasgow 35 | Scotland | British | Chief Executive | 152246840001 | ||||
PRITCHARD, William Boggett | Administrateur | Govan Road G51 4RA Glasgow 1224 Strathclyde | United Kingdom | British | Retired | 34589180002 | ||||
SHANKS, Norman James, Rev Dr | Administrateur | 1 Marchmont Terrace G12 9LT Glasgow | Scotland | British | Minister | 49112330001 | ||||
THOMAS, Fariha Janet | Administrateur | 840-860 Govan Road Govan G51 3UU Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Councillor | 84599760001 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE PEARCE INSTITUTE ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
24 oct. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0