GLADEDALE VENTURES (WESTHILL SHOPPING CENTRE) LIMITED

GLADEDALE VENTURES (WESTHILL SHOPPING CENTRE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGLADEDALE VENTURES (WESTHILL SHOPPING CENTRE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC313937
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GLADEDALE VENTURES (WESTHILL SHOPPING CENTRE) LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe GLADEDALE VENTURES (WESTHILL SHOPPING CENTRE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Regency House
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GLADEDALE VENTURES (WESTHILL SHOPPING CENTRE) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GLADEDALE CAPITAL (WESTHILL SHOPPING CENTRE) LIMITED11 janv. 200711 janv. 2007
    WESTHILLS SHOPPING CENTRE LIMITED28 déc. 200628 déc. 2006

    Quels sont les derniers comptes de GLADEDALE VENTURES (WESTHILL SHOPPING CENTRE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour GLADEDALE VENTURES (WESTHILL SHOPPING CENTRE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mars 2011

    État du capital au 03 mars 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomination de Paul Curran en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Gaffney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Neil Fitzsimmons en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de 15 Lauriston Place Edinburgh EH3 9EN le 02 févr. 2010

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 29 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Dominic Lavelle en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robin Johnson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Joanne Elizabeth Massey en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Modification des coordonnées du secrétaire Robin Simon Johnson le 24 nov. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dominic Joseph Lavelle le 06 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Gaffney le 13 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    10 pages288a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de GLADEDALE VENTURES (WESTHILL SHOPPING CENTRE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147808940001
    CURRAN, Paul
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector110978610002
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector69006050002
    BYRNE, Rosemary
    22 Saltire Street
    EH5 1PT Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    22 Saltire Street
    EH5 1PT Edinburgh
    Midlothian
    British108647330002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MILLIGAN, Michael
    3 Haining Valley Steading
    EH49 6LN Linlithgow
    West Lothian
    Secrétaire
    3 Haining Valley Steading
    EH49 6LN Linlithgow
    West Lothian
    BritishAccountant122258600001
    BRODIES SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    Midlothian
    79799970001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director35117250001
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector84605410002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCro137285750001
    MCINTYRE, James
    2 Whinny View
    EH32 0UJ Aberlady
    East Lothian
    Administrateur
    2 Whinny View
    EH32 0UJ Aberlady
    East Lothian
    BritishCompany Director108647410001
    SMITH, Martin James Alexander
    76 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DN Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    76 Douglas Park Crescent
    Bearsden
    G61 3DN Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor116879890001
    ATHOLL INCORPORATIONS LIMITED
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    Administrateur
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    71782840001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0