MDNX S1 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMDNX S1 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC314337
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MDNX S1 LIMITED ?

    • Activités de télécommunications filaires (61100) / Information et communication
    • Traitement de données, hébergement et activités connexes (63110) / Information et communication

    Où se situe MDNX S1 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    272 Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MDNX S1 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SOLUTION1 (HOLDINGS) LIMITED30 janv. 200730 janv. 2007
    SOLUTION 1 (HOLDINGS) LIMITED09 janv. 200709 janv. 2007

    Quels sont les derniers comptes de MDNX S1 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour MDNX S1 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Yasmin Jaffer en tant que directeur le 13 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Catherine Birkett le 02 oct. 2017

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 09 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de John Allan Shearing en tant que directeur le 15 nov. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    16 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 févr. 2016

    État du capital au 02 févr. 2016

    • Capital: GBP 184
    SH01

    Satisfaction de la charge SC3143370012 en totalité

    1 pagesMR04

    Période comptable actuelle prolongée du 30 nov. 2015 au 31 déc. 2015

    1 pagesAA01

    Nomination de Catherine Birkett en tant qu'administrateur le 15 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Yasmin Jaffer en tant qu'administrateur le 15 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Gareth John Williams en tant qu'administrateur le 15 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de John Shearing en tant qu'administrateur le 15 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark James Thompson en tant que directeur le 15 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Timothy Mulford en tant que directeur le 15 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Wayne Winston Churchill en tant que directeur le 15 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2014

    16 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2015 au 30 nov. 2014

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 févr. 2015

    État du capital au 02 févr. 2015

    • Capital: GBP 184
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Inscription de la charge SC3143370012, créée le 10 janv. 2014

    60 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de MDNX S1 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BIRKETT, Catherine
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    Administrateur
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    EnglandBritish201977420002
    WILLIAMS, Gareth John
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    Administrateur
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    United KingdomBritish126668950001
    CAMERON, Ruth Alexander
    19 Russell Place
    EH5 3HQ Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    19 Russell Place
    EH5 3HQ Edinburgh
    Midlothian
    British111667160001
    GINN, William Thomas, Dr
    Grey House Stables
    Earlstone Common
    RG20 9HN Burghclere
    Berkshire
    Secrétaire
    Grey House Stables
    Earlstone Common
    RG20 9HN Burghclere
    Berkshire
    British119662340001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Secrétaire désigné
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    CAMERON, Keith Donald William
    19 Russell Place
    EH5 3HQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    19 Russell Place
    EH5 3HQ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish111667100001
    CHURCHILL, Wayne Winston
    Oldbury
    RG12 8TH Bracknell
    St James House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Oldbury
    RG12 8TH Bracknell
    St James House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandSouth African155037400001
    DRINKWATER, John
    21a Kings Road
    TW10 6NN Richmond
    Surrey
    Administrateur
    21a Kings Road
    TW10 6NN Richmond
    Surrey
    EnglandBritish81065570001
    GINN, William Thomas, Dr
    Grey House Stables
    Earlstone Common
    RG20 9HN Burghclere
    Berkshire
    Administrateur
    Grey House Stables
    Earlstone Common
    RG20 9HN Burghclere
    Berkshire
    United KingdomBritish119662340001
    JAFFER, Yasmin
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    Administrateur
    c/o Interoute Communications Limited
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    BulgariaBritish202048620001
    JARDINE, Paul
    32 Woodlands Gate
    Woodlands Way, Putney
    SW15 2SY London
    Administrateur
    32 Woodlands Gate
    Woodlands Way, Putney
    SW15 2SY London
    United KingdomBritish119872110001
    KEARSEY, Sion Paul
    12 Ferncroft Avenue
    NW3 7PH London
    Administrateur
    12 Ferncroft Avenue
    NW3 7PH London
    EnglandBritish86251600003
    MULFORD, Michael Timothy
    Oldbury
    RG12 8TH Bracknell
    St James House
    Berkshire
    Administrateur
    Oldbury
    RG12 8TH Bracknell
    St James House
    Berkshire
    EnglandBritish20912630005
    SHEARING, John Allan
    c/o Interoute Communications Limtied
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    Administrateur
    c/o Interoute Communications Limtied
    25 Canada Square
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    BelgiumBritish191514220001
    THOMPSON, Mark James
    Oldbury
    RG12 8TH Bracknell
    St James House
    Berkshire
    Administrateur
    Oldbury
    RG12 8TH Bracknell
    St James House
    Berkshire
    United KingdomBritish136456200001
    WILLIAMS, Richard Mark
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UB Reading
    200
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Brook Drive
    Green Park
    RG2 6UB Reading
    200
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish155149530001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Administrateur désigné
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MDNX S1 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mdnx Limited
    25 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    06 avr. 2016
    25 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5LQ London
    31st Floor
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleUk Companies Act
    Lieu d'enregistrementUk
    Numéro d'enregistrement07374237
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    MDNX S1 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 10 janv. 2014
    Livré le 14 janv. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    An accession deed ot the security agreement dated 10/12/13 see form for further details. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Highbridge Principal Strategies Llc
    Transactions
    • 14 janv. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 05 nov. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 03 août 2012
    Livré le 21 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 21 août 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 03 août 2012
    Livré le 21 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 21 août 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Security agreement
    Créé le 23 juin 2011
    Livré le 05 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First fixed and floating charge over all rights and interests (please see form for more details).
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 13 juil. 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 21 août 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 27 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 23 juin 2011
    Livré le 05 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 13 juil. 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 21 août 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 27 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Composite debenture
    Créé le 30 sept. 2010
    Livré le 14 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Beechbrook Mezzanine I Gp Limited
    Transactions
    • 14 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 19 oct. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 juil. 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 août 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 30 sept. 2010
    Livré le 14 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Beechbrook Mezzanine I Gp Limited
    Transactions
    • 14 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 19 oct. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 juil. 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 août 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Security agreement
    Créé le 30 sept. 2010
    Livré le 13 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First fixed and floating charge over all rights and interests.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Michael Sherwood & Another
    Transactions
    • 13 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 19 oct. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 30 sept. 2010
    Livré le 13 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Michael Sherwood & Another
    Transactions
    • 13 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 19 oct. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Security agreement
    Créé le 30 sept. 2010
    Livré le 12 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    First fixed and floating charge over rights and interests (please see form for more details).
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 12 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 19 oct. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 30 sept. 2010
    Livré le 12 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 12 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 19 oct. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 06 mars 2007
    Livré le 21 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 21 mars 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0