TELFORD HOMES (CREEKSIDE) LIMITED

TELFORD HOMES (CREEKSIDE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTELFORD HOMES (CREEKSIDE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC314992
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TELFORD HOMES (CREEKSIDE) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe TELFORD HOMES (CREEKSIDE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TELFORD HOMES (CREEKSIDE) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LOTHIAN SHELF (607) LIMITED19 janv. 200719 janv. 2007

    Quels sont les derniers comptes de TELFORD HOMES (CREEKSIDE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour TELFORD HOMES (CREEKSIDE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Monique Chantal Woudberg le 22 févr. 2021

    1 pagesCH03

    Déclaration de confirmation établie le 19 janv. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2019

    13 pagesAA

    legacy

    59 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Déclaration de confirmation établie le 19 janv. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2020 au 31 déc. 2019

    1 pagesAA01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2019

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Graham Wiseman en tant que directeur le 01 oct. 2019

    1 pagesTM01

    legacy

    115 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Cessation de la nomination de David Myles Campbell en tant que directeur le 08 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 19 janv. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2018

    15 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Myles Campbell le 20 oct. 2018

    2 pagesCH01

    legacy

    114 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Nomination de Mrs Monique Chantal Woudberg en tant que secrétaire le 30 janv. 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Colin Ellis en tant que secrétaire le 30 janv. 2018

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de TELFORD HOMES (CREEKSIDE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CASWELL, Monique Chantal
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Secrétaire
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    242783890002
    DI STEFANO, Jonathan Graham
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Administrateur
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United KingdomBritish86361540007
    FITZGERALD, John Anthony
    Sharmans Close
    Digswell Welwyn
    AL6 0AR Hertfordshire
    6
    England
    Administrateur
    Sharmans Close
    Digswell Welwyn
    AL6 0AR Hertfordshire
    6
    England
    United KingdomBritish111678660003
    ROGERS, Katie
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Administrateur
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandBritish161720120002
    DEBENHAM, Sara Louise
    First Floor Stuart House
    Queensgate Britannia Road
    EN8 7TF Waltham Cross
    Telford Homes Plc
    Hertfordshire
    England
    Secrétaire
    First Floor Stuart House
    Queensgate Britannia Road
    EN8 7TF Waltham Cross
    Telford Homes Plc
    Hertfordshire
    England
    British154407280001
    ELLIS, Richard Colin
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Secrétaire
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    British173112660001
    ESSLEMONT, Deborah Susan
    The Granary
    Baads Mill
    EH55 8LG West Calder
    West Lothian
    Secrétaire
    The Granary
    Baads Mill
    EH55 8LG West Calder
    West Lothian
    British72983900006
    FERNANDES, Katherine Liza Antoinetta
    92
    Wakemans Hill Avenue, Kingsbury
    NW9 OUR London
    92
    Secrétaire
    92
    Wakemans Hill Avenue, Kingsbury
    NW9 OUR London
    92
    150949000001
    BURNESS LLP
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Secrétaire
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    99448920001
    CAMPBELL, David Myles
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Administrateur
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    EnglandBritish115929220010
    ELLIOTT, Roderick Andrew
    85 Malbet Park
    EH16 6WB Edinburgh
    Administrateur
    85 Malbet Park
    EH16 6WB Edinburgh
    ScotlandIrish77340290001
    ELLWOOD, Sheena
    First Floor
    Queensgate, Britannia Road
    EN8 7TF Waltham Cross
    Stuart House
    Herts
    England
    Administrateur
    First Floor
    Queensgate, Britannia Road
    EN8 7TF Waltham Cross
    Stuart House
    Herts
    England
    EnglandBritish77873760002
    FENNELL, Liam Hugh
    Craighouse Road
    EH10 5LQ Edinburgh
    9
    Administrateur
    Craighouse Road
    EH10 5LQ Edinburgh
    9
    United KingdomBritish131381040001
    HUTCHINSON, Andrew Paul
    54 Bruntsfield Gardens
    EH10 4DY Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    54 Bruntsfield Gardens
    EH10 4DY Edinburgh
    Midlothian
    British96424370001
    ROWNEY, James Mccubbin
    13 Bonaly Gardens
    EH13 0EX Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    13 Bonaly Gardens
    EH13 0EX Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish59551350002
    WISEMAN, Andrew Graham
    Eglington Road
    Chingford
    E4 7AN London
    25
    Administrateur
    Eglington Road
    Chingford
    E4 7AN London
    25
    United KingdomBritish900300002
    BURNESS (DIRECTORS) LIMITED
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Administrateur désigné
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    900019120001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TELFORD HOMES (CREEKSIDE) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Telford Homes Plc
    Queensgate
    Britannia Road
    EN8 7TF Waltham Cross
    Telford House
    England
    06 avr. 2016
    Queensgate
    Britannia Road
    EN8 7TF Waltham Cross
    Telford House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    TELFORD HOMES (CREEKSIDE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 31 mars 2011
    Livré le 08 avr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Debenture
    Créé le 17 sept. 2010
    Livré le 22 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 28 sept. 2010Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 avr. 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 déc. 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Legal charge
    Créé le 12 sept. 2007
    Livré le 14 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 126-180 even creek road; 126-134 even creek road; 140 & 142 creek road & creek road industrial estate; 96-124 creek road & south side of creek road TGL190918 SGL103419 SGL16318 TGL83507 SGL366154 SGL18706.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 sept. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 26 juil. 2007
    Livré le 30 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 126-180 even creek road, 126-134 even creek road, 140 & 142 creek road & creek road industrial estate, 96-124 creek road & south side of creek road, greenwich TGL190918 SGL103419 SGL163318 TGL83507 SGL366154 SGL18706.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 juil. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 29 juin 2007
    Livré le 18 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed charges and floating charge over all assets - see form 410 for details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 juil. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 29 juin 2007
    Livré le 18 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land on the north side of copperas street TGL146908.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 juil. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 29 juin 2007
    Livré le 18 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land on the north west side of copperas street and north side of copperas street and east side of copperas street LN129807 and LN28351.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 juil. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 juil. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0