SCOTTISH CENTRE FOR EXCELLENCE IN DENTISTRY LTD.
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SCOTTISH CENTRE FOR EXCELLENCE IN DENTISTRY LTD. |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC316426 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SCOTTISH CENTRE FOR EXCELLENCE IN DENTISTRY LTD. ?
| Adresse du siège social | Whitehall House 33 Yeaman Shore DD1 4BJ Dundee Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SCOTTISH CENTRE FOR EXCELLENCE IN DENTISTRY LTD. ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 sept. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 juin 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SCOTTISH CENTRE FOR EXCELLENCE IN DENTISTRY LTD. ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 févr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 27 févr. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 févr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour SCOTTISH CENTRE FOR EXCELLENCE IN DENTISTRY LTD. ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Nomination de Marc Alan Hopson en tant qu'administrateur le 03 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Heath Denis Batwell en tant que directeur le 03 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 sept. 2024 | 8 pages | AA | ||
legacy | 84 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Cessation de la nomination de Paul Mark Davis en tant que directeur le 31 mars 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Louise Marie Reeves en tant qu'administrateur le 31 mars 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Robert Andrew Michael Davidson en tant que directeur le 16 août 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 sept. 2023 | 8 pages | AA | ||
legacy | 78 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 2 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 2 pages | GUARANTEE2 | ||
Changement d'adresse du siège social de The Ca'd'oro 45 Gordon Street Glasgow G1 3PE Scotland à Whitehall House 33 Yeaman Shore Dundee DD1 4BJ le 16 févr. 2024 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Heath Denis Batwell en tant qu'administrateur le 28 nov. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 sept. 2022 | 8 pages | AA | ||
legacy | 63 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 2 pages | GUARANTEE2 | ||
Nomination de Mr Paul Mark Davis en tant qu'administrateur le 18 mai 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Michael David Killick en tant que directeur le 18 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 12 Hope Street Edinburgh EH2 4DB Scotland à The Ca'd'oro 45 Gordon Street Glasgow G1 3PE le 12 avr. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 févr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de SCOTTISH CENTRE FOR EXCELLENCE IN DENTISTRY LTD. ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOPSON, Marc Alan | Administrateur | 33 Yeaman Shore DD1 4BJ Dundee Whitehall House Scotland | England | British | 343505750001 | |||||
| REEVES, Louise Marie | Administrateur | 33 Yeaman Shore DD1 4BJ Dundee Whitehall House Scotland | England | British | 334514670001 | |||||
| SADLER, Rebecca Peta, Dr | Administrateur | New Barn Lane GL52 3LZ Cheltenham Rosehill England | England | British | 180977660002 | |||||
| TANNAHILL, Catherine Julia | Administrateur | 33 Yeaman Shore DD1 4BJ Dundee Whitehall House Scotland | England | British | 192354480001 | |||||
| ALI, Nassim Akhtar | Secrétaire | 335 Govan Road G51 2SE Govan Watermark Business Park Glasgow | British | 119204950001 | ||||||
| MILNE, Darren James Ivor | Secrétaire | Hope Street EH2 4DB Edinburgh 12 Scotland | 263399720001 | |||||||
| BRIAN REID LTD. | Secrétaire désigné | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park Logie Green Road EH7 4HH Edinburgh | 900018660001 | |||||||
| ALI, Arshad | Administrateur | 335 Govan Road G51 2SE Govan Watermark Business Park Glasgow | Scotland | British | 119204860001 | |||||
| BATWELL, Heath Denis | Administrateur | 33 Yeaman Shore DD1 4BJ Dundee Whitehall House Scotland | England | British | 316462040001 | |||||
| COHEN, Christopher Ben | Administrateur | New Barn Lane GL52 3LZ Cheltenham Rose Hill Gloucestershire England | England | British | 266773220001 | |||||
| DAVIDSON, Robert Andrew Michael | Administrateur | 33 Yeaman Shore DD1 4BJ Dundee Whitehall House Scotland | Scotland | Irish | 302852770001 | |||||
| DAVIS, Paul Mark | Administrateur | New Barn Lane GL52 3LZ Cheltenham Rosehill England | England | British | 279020820001 | |||||
| HAMBURGER, Mark Howard, Dr | Administrateur | New Barn Lane GL52 3LZ Cheltenham Rosehill England | England | British,Israeli | 96368840002 | |||||
| KILLICK, Michael David | Administrateur | 45 Gordon Street G1 3PE Glasgow The Ca'D'Oro Scotland | England | British | 204861480001 | |||||
| MILNE, Darren James Ivor | Administrateur | New Barn Lane GL52 3LZ Cheltenham Rosehill England | England | British | 81762570002 | |||||
| MUIR, Scot | Administrateur | 335 Govan Road G51 2SE Govan Watermark Business Park Glasgow | Scotland | British | 117062970001 | |||||
| SAUNDERS, Christopher Ian | Administrateur | Hope Street EH2 4DB Edinburgh 12 Scotland | England | British | 205201250001 | |||||
| STEPHEN MABBOTT LTD. | Administrateur désigné | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | 900018650001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SCOTTISH CENTRE FOR EXCELLENCE IN DENTISTRY LTD. ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portman Healthcare Limited | 04 oct. 2019 | New Barn Lane GL52 3LZ Cheltenham Rosehill England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Aa Dental Services (Scotland) Limited | 06 nov. 2017 | 335 Govan Road G51 2SE Glasgow Watermark Business Park Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Aa Dental Services (Scotland) Limited | 06 nov. 2017 | Hope Street EH2 4DB Edinburgh 12 Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Fraoch Northfield Limited | 08 déc. 2016 | Northfield ML11 0JE Lesmahagow Fraoch House Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Fraoch Northfield Limited | 08 déc. 2016 | Hope Street EH2 4DB Edinburgh 12 Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Arshad Ali | 06 avr. 2016 | 335 Govan Road G51 2SE Govan Watermark Business Park Glasgow United Kingdom | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Scot Muir | 06 avr. 2016 | 335 Govan Road G51 2SE Govan Watermark Business Park Glasgow United Kingdom | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0