CEIS AYRSHIRE

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCEIS AYRSHIRE
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société SC327751
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CEIS AYRSHIRE ?

    • Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques n.c.a. (74909) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CEIS AYRSHIRE ?

    Adresse du siège social
    Landek House Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CEIS AYRSHIRE ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CEIS AYRSHIRE ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au13 juil. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation27 juil. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au13 juil. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour CEIS AYRSHIRE ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes annuels établis au 31 mars 2025

    33 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2024

    34 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr John Godwin en tant qu'administrateur le 17 avr. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Martin Avila en tant que secrétaire le 24 nov. 2023

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Joanne Elizabeth Seagrave en tant que secrétaire le 24 nov. 2023

    2 pagesAP03

    Comptes annuels établis au 31 mars 2023

    31 pagesAA

    Nomination de Mr Greig Robson en tant qu'administrateur le 18 août 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Laura Ellen Worku en tant que directeur le 06 oct. 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Gillian Louise Fyfe en tant qu'administrateur le 18 août 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Martin Avila en tant que secrétaire le 18 août 2023

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Fiona Ann Mcclune en tant que secrétaire le 18 août 2023

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Julie Mclachlan en tant que directeur le 12 juin 2023

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Gunjan Yadav le 07 mars 2023

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2022

    29 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Gerald David Lindsay en tant qu'administrateur le 01 juin 2022

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Landek House Landek House Suite 3, 2nd Floor, 46 Bank Street Irvine KA12 0HL Scotland à Landek House Suite 3, 2nd Floor 46 Bank Street Irvine KA12 0HL le 10 mai 2022

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 26 Eglinton Street Irvine Ayrshire KA12 8AS à Landek House Landek House Suite 3, 2nd Floor, 46 Bank Street Irvine KA12 0HL le 28 avr. 2022

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2021

    34 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Ian Mitchell en tant que directeur le 10 mai 2021

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2020

    29 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CEIS AYRSHIRE ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SEAGRAVE, Joanne Elizabeth
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    Secrétaire
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    316672570001
    BRISTOW, James Roland
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    Administrateur
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    ScotlandBritish750060001
    FYFE, Gillian Louise
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    Administrateur
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    ScotlandScottish302164870001
    FYFE, Sheila Catherine
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    Administrateur
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    ScotlandBritish208759520001
    GODWIN, John
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    Administrateur
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    ScotlandBritish87990380001
    LINDSAY, Gerald David
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    Administrateur
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    ScotlandBritish69825240002
    ROBSON, Greig
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    Administrateur
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    ScotlandBritish314405800001
    YADAV, Gunjan
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    Administrateur
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    EnglandIndian265397370002
    AVILA, Martin
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    Secrétaire
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    312749700001
    HAMILL, Stephen Andrew
    Netherlee Crescent
    KA24 5HF Dalry
    13
    North Ayrshire
    Secrétaire
    Netherlee Crescent
    KA24 5HF Dalry
    13
    North Ayrshire
    British137183990001
    MCCLUNE, Fiona Ann
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    Secrétaire
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    203643230001
    NICOL, Deborah
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    Secrétaire
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    181434350001
    ANDERSON, Alexander
    25 Poplar Way
    Viewpark
    KA7 3PQ Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    25 Poplar Way
    Viewpark
    KA7 3PQ Ayr
    Ayrshire
    United KingdomBritish122976360001
    EBBITT, Stephen Frederick
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    Administrateur
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    ScotlandBritish19216100004
    FAWDRY, Fiona Leiper Alxander
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    Administrateur
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    ScotlandScottish251779030001
    GEDDES, Norman George
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    Administrateur
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    United KingdomBritish346700005
    HAMILTON, Neil Thomas Hunter
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    Administrateur
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    ScotlandBritish711760003
    HIGGINS, Gerard Patrick
    11 Barrmill Road
    KA15 1EU Beith
    Ayrshire
    Administrateur
    11 Barrmill Road
    KA15 1EU Beith
    Ayrshire
    ScotlandIrish112240580001
    MCCANN, Evelyn
    68 Ardrossan Road
    Seamill
    KA23 9LX West Kilbride
    Ayrshire
    Administrateur
    68 Ardrossan Road
    Seamill
    KA23 9LX West Kilbride
    Ayrshire
    ScotlandBritish72087850001
    MCLACHLAN, Julie
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    Administrateur
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    ScotlandScottish265871920001
    MITCHELL, Ian
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    Administrateur
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    ScotlandBritish202630700001
    MURRAY MBE, Lorraine
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    Administrateur
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    ScotlandBritish141010780003
    RUSSELL, Valerie Anne
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    Administrateur
    26 Eglinton Street
    Irvine
    KA12 8AS Ayrshire
    ScotlandBritish167968110001
    THOMAS, Elizabeth
    Mansewood Road
    G43 1BP Glasgow
    97
    Administrateur
    Mansewood Road
    G43 1BP Glasgow
    97
    ScotlandBritish86043760001
    WORKU, Laura Ellen
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    Administrateur
    Suite 3, 2nd Floor
    46 Bank Street
    KA12 0HL Irvine
    Landek House
    Scotland
    ScotlandBritish268468600001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CEIS AYRSHIRE ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    5
    Scotland
    06 avr. 2016
    Dava Street
    G51 2JA Glasgow
    5
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Guarantee
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc087515
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0