STUDIOFV LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTUDIOFV LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC332476
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STUDIOFV LIMITED ?

    • Éducation culturelle (85520) / Enseignement

    Où se situe STUDIOFV LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Paisley Centre Unit 22, Paisley Centre
    23 High Street
    PA1 2AQ Paisley
    Renfrewshire
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STUDIOFV LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FABLEVISION STUDIOS LIMITED16 févr. 200916 févr. 2009
    'IF POSSIBLE!' LTD.16 oct. 200716 oct. 2007

    Quels sont les derniers comptes de STUDIOFV LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour STUDIOFV LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au07 mars 2023

    Quels sont les derniers dépôts pour STUDIOFV LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Mark Steven Hibbert en tant que directeur le 01 déc. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022

    13 pagesAA

    Nomination de Mr Robert David Calder en tant qu'administrateur le 24 juin 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Diana Alexandra Dumitrescu en tant que directeur le 24 juin 2022

    1 pagesTM01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed fablevision studios LIMITED\certificate issued on 08/06/22
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name08 juin 2022

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Unit 24, Paisley Centre, 23 High Street, Paisley, Unit 24, Paisley Centre, 23 High Street Paisley Renfrewshire PA1 2AQ Scotland à Paisley Centre Unit 22, Paisley Centre 23 High Street Paisley Renfrewshire PA1 2AQ le 04 mai 2022

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2021

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020

    13 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Edward Richard Hart le 30 oct. 2020

    2 pagesCH01

    Nomination de Miss Louisa Gardiner-Taylor en tant qu'administrateur le 17 avr. 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 24 Unit 24 24 High Street Paisley Renfrewshire PA1 2AQ Scotland à Unit 24, Paisley Centre, 23 High Street, Paisley, Unit 24, Paisley Centre, 23 High Street Paisley Renfrewshire PA1 2AQ le 22 avr. 2020

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Unit 24, Paisley Centre, 23 High Street, Paisley, High Street Paisley PA1 2AQ Scotland à 24 Unit 24 24 High Street Paisley Renfrewshire PA1 2AQ le 22 avr. 2020

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor, 7 Water Row Govan Glasgow Strathclyde G51 3UW à Unit 24, Paisley Centre, 23 High Street, Paisley, High Street Paisley PA1 2AQ le 22 avr. 2020

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2018

    10 pagesAA

    Nomination de Ms Diana Alexandra Dumitrescu en tant qu'administrateur le 30 sept. 2018

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de STUDIOFV LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CALDER, Robert David
    Unit 22
    23 High Street
    PA1 2AQ Paisley
    Unit 22, 23 High Street, Paisley
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    Unit 22
    23 High Street
    PA1 2AQ Paisley
    Unit 22, 23 High Street, Paisley
    Renfrewshire
    Scotland
    ScotlandScottish297678560001
    GARDINER-TAYLOR, Louisa
    Unit 22, Paisley Centre
    23 High Street
    PA1 2AQ Paisley
    Paisley Centre
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    Unit 22, Paisley Centre
    23 High Street
    PA1 2AQ Paisley
    Paisley Centre
    Renfrewshire
    Scotland
    ScotlandScottish269302150001
    HART, Edward Richard
    Unit 22, Paisley Centre
    23 High Street
    PA1 2AQ Paisley
    Paisley Centre
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    Unit 22, Paisley Centre
    23 High Street
    PA1 2AQ Paisley
    Paisley Centre
    Renfrewshire
    Scotland
    ScotlandBritish206416040002
    FRASER, Iain
    Lorien, 36 Elizabeth Crescent
    IV25 3NN Dornoch
    Sutherland
    Secrétaire
    Lorien, 36 Elizabeth Crescent
    IV25 3NN Dornoch
    Sutherland
    British126074800001
    GARDINER, Elizabeth Mclellan
    5a
    High Calside
    PA2 6BY Paisley
    Renfrewshire
    Secrétaire
    5a
    High Calside
    PA2 6BY Paisley
    Renfrewshire
    British716540001
    PETER TRAINER COMPANY SECRETARIES LTD.
    27 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Secrétaire désigné
    27 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    900018690001
    DENNING, Philip John
    2a Ventnor Terrace
    EH9 2BW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    2a Ventnor Terrace
    EH9 2BW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish67029230001
    DUMITRESCU, Diana Alexandra
    13 Grovepark Gardens,
    G20 7JB Glasgow
    Flat H
    Scotland
    Administrateur
    13 Grovepark Gardens,
    G20 7JB Glasgow
    Flat H
    Scotland
    ScotlandRomanian253000830001
    FRASER, Ailsa
    Lorien, 36 Elizabeth Crescent
    IV25 3NN Dornoch
    Sutherland
    Administrateur
    Lorien, 36 Elizabeth Crescent
    IV25 3NN Dornoch
    Sutherland
    British126074760001
    FRASER, Iain
    Lorien, 36 Elizabeth Crescent
    IV25 3NN Dornoch
    Sutherland
    Administrateur
    Lorien, 36 Elizabeth Crescent
    IV25 3NN Dornoch
    Sutherland
    British126074800001
    GARDINER, Elizabeth Mclellan
    5a
    High Calside
    PA2 6BY Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    5a
    High Calside
    PA2 6BY Paisley
    Renfrewshire
    United KingdomBritish716540001
    HAMILTON, Alasdair
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    Administrateur
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    ScotlandBritish149502120001
    HIBBERT, Mark Steven, Mr.
    Crosbie Street
    G20 0BB Glasgow
    32
    Scotland
    Administrateur
    Crosbie Street
    G20 0BB Glasgow
    32
    Scotland
    ScotlandBritish93661290006
    HUNTER, Gordon Mcgregor
    Dumbrock Road
    Milngavie
    G62 7RB Glasgow
    42
    Scotland
    Administrateur
    Dumbrock Road
    Milngavie
    G62 7RB Glasgow
    42
    Scotland
    United KingdomBritish178652290001
    KINDLEN, Simon Peter
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    Administrateur
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    ScotlandScottish149602510001
    LAUCHLAN, Elizabeth Margaret
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    Administrateur
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    United KingdomBritish149499520001
    MARTIN, Andrew
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    Administrateur
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    ScotlandBritish206397980001
    MARTIN, Cliff Robert
    Burnmouth Place
    Bearsden
    G61 3PG Glasgow
    27
    Scotland
    Administrateur
    Burnmouth Place
    Bearsden
    G61 3PG Glasgow
    27
    Scotland
    ScotlandBritish79575340003
    MCGLENNON, Christopher
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    Administrateur
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    ScotlandScottish149501770001
    MELVILLE, John
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    Administrateur
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    ScotlandScottish149501860001
    O'KANE, Christopher Anthony, Mr.
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    Administrateur
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    ScotlandScottish129442880001
    PORTER, Agnes Samuel
    Caledon Lane
    G12 9YE Glasgow
    The Mews
    Scotland
    Administrateur
    Caledon Lane
    G12 9YE Glasgow
    The Mews
    Scotland
    United KingdomBritish177262530001
    TAYLOR, Louisa Gardiner
    Woodrow Road
    G41 5PN Glasgow
    4 Woodrow Court
    Scotland
    Administrateur
    Woodrow Road
    G41 5PN Glasgow
    4 Woodrow Court
    Scotland
    ScotlandBritish197420790001
    WALSH, Catherine Jude
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    Administrateur
    Water Row
    Govan
    G51 3UW Glasgow
    3rd Floor, 7
    Strathclyde
    ScotlandIrish149501620001
    PETER TRAINER COMPANY SECRETARIES LTD.
    27 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Administrateur désigné
    27 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    900018690001
    PETER TRAINER CORPORATE SERVICES LTD.
    27 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    Administrateur désigné
    27 Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    900025460001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour STUDIOFV LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    30 avr. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0