MHA AUCHLOCHAN

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMHA AUCHLOCHAN
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société SC352117
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MHA AUCHLOCHAN ?

    • Activités de soins résidentiels pour les personnes âgées et handicapées (87300) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe MHA AUCHLOCHAN ?

    Adresse du siège social
    Titanium 1 Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MHA AUCHLOCHAN ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2023
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2023
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MHA AUCHLOCHAN ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au24 oct. 2023
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation07 nov. 2023
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au24 oct. 2022
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour MHA AUCHLOCHAN ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    36 pagesAM10(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    41 pagesAM10(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    5 pagesAM19(Scot)

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:amended form AM01(scot) notice of administrators appointment
    4 pagesLIQ MISC

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    42 pagesAM10(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    40 pagesAM10(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    4 pagesAM19(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    42 pagesAM10(Scot)

    Cessation de la nomination de Janet Hunter Haugh en tant que directeur le 25 juil. 2023

    1 pagesTM01

    Décision des créanciers sur les propositions de l'administrateur

    6 pagesAM07(Scot)

    Avis de proposition de l'administrateur

    62 pagesAM03(Scot)

    Déclaration des affaires AM02SOASCOT/AM02SOCSCOT

    17 pagesAM02(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Auchlochan House New Trows Road Lesmahagow Lanarkshire ML11 0JS à Titanium 1 Kings Inch Place Renfrew PA4 8WF le 09 mai 2023

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    4 pagesAM01(Scot)

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Proposed transdaction approved and article 25 disapplied to allow participation 20/03/2023
    RES13

    Comptes annuels établis au 31 mars 2022

    36 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Hilary Margaret Cocker en tant que directeur le 31 oct. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Martin Burkitt en tant qu'administrateur le 20 avr. 2022

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2021

    43 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MHA AUCHLOCHAN ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MOTTRAM, Mandy Joanne
    Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    Secrétaire
    Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    247039100001
    BURKITT, Martin
    Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    Administrateur
    Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Titanium 1
    EnglandBritish260081290001
    REILLY, James Anthony
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Epworth House
    England
    Administrateur
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Epworth House
    England
    EnglandBritish106671940001
    ALLEN, Jacqueline Anne
    Blue Mountains
    Duffield
    DE56 4BN Belper
    8
    Derbyshire
    Secrétaire
    Blue Mountains
    Duffield
    DE56 4BN Belper
    8
    Derbyshire
    British136547890001
    BAGG, Adrian
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Epworth House
    England
    Secrétaire
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Epworth House
    England
    198728230001
    DAVIES, Roger John
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Mha Epworth House
    England
    Secrétaire
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Mha Epworth House
    England
    174857270001
    FRASER, Stephen John
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Epworth House
    England
    Secrétaire
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Epworth House
    England
    184139150001
    HAYWARD, David James
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    Secrétaire
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    159527650001
    TERRY, Mark
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    Secrétaire
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    202113250001
    T C YOUNG
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Secrétaire
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    92309420001
    BARCLAY, Peter, Reverend
    Pitlochry Close
    BS7 0TU Bristol
    4
    Avon
    Administrateur
    Pitlochry Close
    BS7 0TU Bristol
    4
    Avon
    United KingdomBritish135405060001
    BOGGIS, Peter Martin, Mr.
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    Administrateur
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    EnglandBritish83796170001
    BROWN, Susanne Moira, Professor
    Kilure
    7 The Steading, Croy Cunningham, Killearn
    G63 9QY Glasgow
    Administrateur
    Kilure
    7 The Steading, Croy Cunningham, Killearn
    G63 9QY Glasgow
    ScotlandBritish68224530002
    COCKER, Hilary Margaret
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Epworth House
    England
    Administrateur
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Epworth House
    England
    EnglandBritish146002630003
    COLDWELL, Brian Brook
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    Administrateur
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    United KingdomBritish62951280002
    DRIFE, Alice
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Mha Epworth House
    England
    Administrateur
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Mha Epworth House
    England
    ScotlandScottish157829140001
    EWING, Mark Espie
    Baldernock Glebe
    Baldernock, Milngavie
    G62 6HA Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Baldernock Glebe
    Baldernock, Milngavie
    G62 6HA Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandScottish66920100001
    FLYNN, Suzanne Gramina
    Greenhill
    Darvel
    KA17 0LN Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    Greenhill
    Darvel
    KA17 0LN Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritish43534360001
    FRASER, Stephen John
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    Administrateur
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    EnglandBritish130360060004
    HALL, David, Dr
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    Administrateur
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    EnglandBritish41182330001
    HAUGH, Janet Hunter
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Epworth House
    England
    Administrateur
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Epworth House
    England
    ScotlandBritish260437210001
    JACKSON, Vanella Jane
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    Administrateur
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    United KingdomBritish101163980001
    KINGSBURY, Joy
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    Administrateur
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    EnglandBritish194261670001
    MASON, Andrew Paul
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    Administrateur
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    United KingdomBritish110611200001
    MORGAN, Shelagh
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    Administrateur
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    EnglandBritish74042250001
    PARK, Lawrence William
    South Lodge
    Auchlochan New Trows Road
    ML11 0GS Lesmahagow
    Lanarkshire
    Administrateur
    South Lodge
    Auchlochan New Trows Road
    ML11 0GS Lesmahagow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish127422320001
    RIDDELL, Susan
    Epworth House
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Mha
    Derbyshire
    England
    Administrateur
    Epworth House
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Mha
    Derbyshire
    England
    ScotlandScottish183017190001
    SCOTT, Innis
    Epworth House
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Mha
    Derbyshire
    England
    Administrateur
    Epworth House
    Stuart Street
    DE1 2EQ Derby
    Mha
    Derbyshire
    England
    ScotlandBritish183017020001
    STEELE, George Dennis
    The Link House Auchlochan
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Lanarkshire
    Administrateur
    The Link House Auchlochan
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish127422600001
    TERRY, Mark
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    Administrateur
    New Trows Road
    ML11 0JS Lesmahagow
    Auchlochan House
    Lanarkshire
    EnglandBritish222173090001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour MHA AUCHLOCHAN ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    25 oct. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    MHA AUCHLOCHAN a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 mai 2024Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Young
    2nd Floor Regis House 45 King William Street
    EC4R 9AN London
    practitioner
    2nd Floor Regis House 45 King William Street
    EC4R 9AN London
    Blair Milne
    Titanium 1 Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Renfrewshire
    practitioner
    Titanium 1 Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Renfrewshire
    James Fennessey
    Titanium 1 Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Glasgow
    practitioner
    Titanium 1 Kings Inch Place
    PA4 8WF Renfrew
    Glasgow

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0