INTERSERVE SCOTLAND AND IRELAND

INTERSERVE SCOTLAND AND IRELAND

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINTERSERVE SCOTLAND AND IRELAND
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société SC369705
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INTERSERVE SCOTLAND AND IRELAND ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe INTERSERVE SCOTLAND AND IRELAND ?

    Adresse du siège social
    Abercorn House
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Renfrewshire
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INTERSERVE SCOTLAND AND IRELAND ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INTERSERVE SCOTLAND07 déc. 200907 déc. 2009

    Quels sont les derniers comptes de INTERSERVE SCOTLAND AND IRELAND ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 avr. 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 janv. 2027
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour INTERSERVE SCOTLAND AND IRELAND ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au07 déc. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation21 déc. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au07 déc. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour INTERSERVE SCOTLAND AND IRELAND ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2025

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 déc. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Kevin Stewart Ashman en tant que directeur le 13 sept. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Iain Guy Dougall en tant que secrétaire le 04 août 2025

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Philip Lewis en tant que secrétaire le 04 août 2025

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Jude Olisa en tant que directeur le 02 nov. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Simon Edward Hocking en tant qu'administrateur le 19 mai 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Iain Guy Dougall en tant que secrétaire le 01 mars 2025

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Christopher James Binder en tant que secrétaire le 01 mars 2025

    1 pagesTM02

    Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2024

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 déc. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 21 21 Park Avenue Bishopbriggs Glasgow G64 2SN Scotland à Abercorn House 79 Renfrew Road Paisley Renfrewshire PA3 4DA le 21 mars 2024

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2023

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 déc. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Emmanuel William Gill en tant qu'administrateur le 02 sept. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gordon Highet Brown en tant que directeur le 02 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Dr Christine Joy Boardman en tant qu'administrateur le 03 juin 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ann Patricia Mcconkey en tant que directeur le 03 juin 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Onkar Singh en tant que directeur le 03 juin 2023

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2022

    19 pagesAA

    Nomination de Mr Alan Butler en tant qu'administrateur le 01 janv. 2023

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 07 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Jilda Clark en tant que directeur le 02 déc. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jane Showell-Rogers en tant que directeur le 05 mars 2022

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 avr. 2021

    19 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de INTERSERVE SCOTLAND AND IRELAND ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEWIS, Philip
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    Secrétaire
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    338829790001
    BOARDMAN, Christine Joy, Dr
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    EnglandBritish310137080001
    BUTLER, Alan Charles
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    EnglandBritish304047510001
    GILL, Emmanuel William
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    EnglandBritish313306040001
    HOCKING, Simon Edward
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    EnglandBritish191917850001
    HOWITT, Jane, Rev
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    ScotlandBritish156472890001
    KEMP, Malcolm
    Alum Rock Road
    B8 3NS Birmingham
    652
    England
    Administrateur
    Alum Rock Road
    B8 3NS Birmingham
    652
    England
    EnglandBritish248922340002
    SMUTS, John, Rev
    Alum Rock Road
    B8 3NS Birmingham
    652
    England
    Administrateur
    Alum Rock Road
    B8 3NS Birmingham
    652
    England
    EnglandBritish248923420002
    TSUNEKAWA BUTTERWORTH, Keiko
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    EnglandJapanese256368600001
    BELL, Steven
    5/6 Walker Avenue
    Wolverton Mill
    MK12 5TW Milton Keynes
    5/6
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    5/6 Walker Avenue
    Wolverton Mill
    MK12 5TW Milton Keynes
    5/6
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    249100910001
    BELL, Steven
    Walker Avenue
    Wolverton Mill
    MK12 5TW Milton Keynes
    5/6
    England
    Secrétaire
    Walker Avenue
    Wolverton Mill
    MK12 5TW Milton Keynes
    5/6
    England
    248776260002
    BINDER, Christopher James
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    Secrétaire
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    269363200001
    DOUGALL, Iain Guy
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    Secrétaire
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    333062160001
    PENNEY, Grace Catherine
    Panorama Business Village
    4 Blairtummock Place Queenslie
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland
    Secrétaire
    Panorama Business Village
    4 Blairtummock Place Queenslie
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland
    147456190002
    WREN, Kevin
    21 Park Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2SN Glasgow
    21
    Scotland
    Secrétaire
    21 Park Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2SN Glasgow
    21
    Scotland
    251250210001
    ASHMAN, Kevin Stewart
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    EnglandBritish266069870001
    BARGE, Jennifer
    Panorama Business Village
    4 Blairtummock Place Queenslie
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland
    Administrateur
    Panorama Business Village
    4 Blairtummock Place Queenslie
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland
    ScotlandBritish147456220001
    BROWN, Gordon Highet
    21 Park Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2SN Glasgow
    21
    Scotland
    Administrateur
    21 Park Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2SN Glasgow
    21
    Scotland
    ScotlandBritish71534760002
    CANNON, Margaret Stewart
    Panorama Business Village
    4 Blairtummock Place Queenslie
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland
    Administrateur
    Panorama Business Village
    4 Blairtummock Place Queenslie
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland
    ScotlandBritish147456200001
    CHACKO, Thomas
    Alum Rock Road
    B8 3NS Birmingham
    652
    England
    Administrateur
    Alum Rock Road
    B8 3NS Birmingham
    652
    England
    EnglandBritish248925980002
    CLARK, Jilda
    21 Park Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2SN Glasgow
    21
    Scotland
    Administrateur
    21 Park Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2SN Glasgow
    21
    Scotland
    ScotlandTurkish262544120001
    DOWNES, Ruth Fiona, Director
    21 Park Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2SN Glasgow
    21
    Scotland
    Administrateur
    21 Park Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2SN Glasgow
    21
    Scotland
    ScotlandBritish147456210001
    DYATT, Barbara
    4 Blairtummock Place
    Panorama Business Village
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland And Ireland
    Scotland
    Administrateur
    4 Blairtummock Place
    Panorama Business Village
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland And Ireland
    Scotland
    Northern IrelandBritish181379090001
    FATEHI, Shadi
    21 Park Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2SN Glasgow
    21
    Scotland
    Administrateur
    21 Park Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2SN Glasgow
    21
    Scotland
    United KingdomBritish262658930001
    GILFILLAN, Rhoda
    4 Blairtummock Place
    Panorama Business Village
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland And Ireland
    Scotland
    Administrateur
    4 Blairtummock Place
    Panorama Business Village
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland And Ireland
    Scotland
    ScotlandBritish156472930002
    HOLMES, Margaret Jemima Joanne
    Brooklands Gardens
    Whitehead
    BT38 9RS Carrickfergus
    33
    County Antrim
    Northern Ireland
    Administrateur
    Brooklands Gardens
    Whitehead
    BT38 9RS Carrickfergus
    33
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish144761270001
    KNIGHT, David James
    Panorama Business Village
    4 Blairtummock Place Queenslie
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland
    Administrateur
    Panorama Business Village
    4 Blairtummock Place Queenslie
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland
    United KingdomBritish147456250001
    LAING, Mark
    21 Park Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2SN Glasgow
    21
    Scotland
    Administrateur
    21 Park Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2SN Glasgow
    21
    Scotland
    ScotlandBritish172739540001
    MCCONKEY, Ann Patricia
    21 Park Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2SN Glasgow
    21
    Scotland
    Administrateur
    21 Park Avenue
    Bishopbriggs
    G64 2SN Glasgow
    21
    Scotland
    Northern IrelandBritish241305780001
    MCILWAINE, Stephen Jonathan
    4 Blairtummock Place
    Panorama Business Village
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland And Ireland
    Scotland
    Administrateur
    4 Blairtummock Place
    Panorama Business Village
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland And Ireland
    Scotland
    Northern IrelandBritish171681810001
    MURRAY, Graham Neil
    4 Blairtummock Place
    Panorama Business Village
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland And Ireland
    Administrateur
    4 Blairtummock Place
    Panorama Business Village
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland And Ireland
    ScotlandBritish156492340001
    MURRAY, Graham Neil
    Panorama Business Village
    4 Blairtummock Place Queenslie
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland
    Administrateur
    Panorama Business Village
    4 Blairtummock Place Queenslie
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland
    ScotlandBritish156492340001
    MURRAY, Graham
    Panorama Business Village
    4 Blairtummock Place Queenslie
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland
    Administrateur
    Panorama Business Village
    4 Blairtummock Place Queenslie
    G33 4EN Glasgow
    Interserve Scotland
    ScotlandBritish156472980001
    OLISA, Jude
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    Administrateur
    79 Renfrew Road
    PA3 4DA Paisley
    Abercorn House
    Renfrewshire
    Scotland
    United KingdomBritish284881430001
    OLIVER-DEE, Sean, Dr
    Alum Rock Road
    B8 3NS Birmingham
    652
    England
    Administrateur
    Alum Rock Road
    B8 3NS Birmingham
    652
    England
    EnglandBritish248926320002

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour INTERSERVE SCOTLAND AND IRELAND ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    07 déc. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0