SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED

SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC390210
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3 Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EVERWARM LTD16 mai 201116 mai 2011
    INSULATION DIRECT SERVICES LIMITED10 déc. 201010 déc. 2010

    Quels sont les derniers comptes de SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au10 nov. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation24 nov. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au10 nov. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de John Spencer Sheridan en tant que directeur le 20 janv. 2026

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 10 nov. 2025 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Inscription de la charge SC3902100012, créée le 17 sept. 2025

    21 pagesMR01

    État du capital après une attribution d'actions au 21 mai 2025

    • Capital: GBP 10,001
    3 pagesSH01

    Satisfaction de la charge SC3902100011 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC3902100010 en totalité

    4 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr. Robert Stirling le 21 mai 2025

    2 pagesCH01

    État du capital au 23 mai 2025

    • Capital: GBP 10,001
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Reduction of share premium account from £18,249,482.67 to £nil 21/05/2025
    RES13

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2024

    27 pagesAA

    Modification des détails de Sureserve Energy Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 févr. 2025

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 10 déc. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed everwarm LTD\certificate issued on 06/12/24
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name06 déc. 2024

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Modification des détails de Sureserve Energy Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 08 avr. 2024

    2 pagesPSC05

    Nomination de Mr Paul John Edwards en tant qu'administrateur le 16 mai 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Spencer John Sheridan en tant qu'administrateur le 16 mai 2024

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2023

    28 pagesAA

    Nomination de Mr Geoffrey Ronald Mayhill en tant que secrétaire le 01 mai 2024

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de John William Charles Charlton en tant que secrétaire le 01 mai 2024

    1 pagesTM02

    Statuts

    11 pagesMA

    Qui sont les dirigeants de SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MAYHILL, Geoffrey Ronald
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Secrétaire
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    322727820001
    EDWARDS, John Paul
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Administrateur
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    EnglandBritish61489610001
    LEVINSOHN, Graham Austen
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Administrateur
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    EnglandBritish254321290002
    STIRLING, Robert, Mr.
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Administrateur
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    ScotlandBritish161206330002
    BROIDER, Philip David
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    Great Britain
    Secrétaire
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    Great Britain
    187066010001
    CHARLTON, John William Charles
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Secrétaire
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    230682790001
    HOWELL, Simon John
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    Secrétaire
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    188413580001
    MCMAHON, Micheal
    Rutland Square
    EH1 2BD Edinburgh
    14
    Midlothian
    Scotland
    Secrétaire
    Rutland Square
    EH1 2BD Edinburgh
    14
    Midlothian
    Scotland
    British157066970001
    TRAINER, Peter
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    27
    Scotland
    Secrétaire
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    27
    Scotland
    British135727620001
    BIRRANE, Sean Thomas
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    Administrateur
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    EnglandBritish101296120004
    BLACK, Stuart John
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    Great Britain
    Administrateur
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    Great Britain
    United KingdomBritish49053310001
    CHARLTON, John William Charles
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Administrateur
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    EnglandBritish119598150002
    COX, Alan Robert
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    England
    Administrateur
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    England
    EnglandBritish119020860001
    GRAHAM, Lydia
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    Administrateur
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    United KingdomBritish1386390002
    MCINTOSH, Susan
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    27
    Scotland
    Administrateur
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    27
    Scotland
    ScotlandBritish44652340001
    MCMAHON, Michael, Mr.
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    Administrateur
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    ScotlandBritish159906060001
    RAWLINGS, Steven Edward
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    Great Britain
    Administrateur
    King George Close
    RM7 7LS Romford
    1
    Essex
    Great Britain
    Great BritainBritish182864270001
    SAUNDERS, Kennedy Forrester
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    Administrateur
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    ScotlandBritish959650004
    SHERIDAN, John Spencer
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Administrateur
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    EnglandBritish238643210001
    SIMPSON, Jeremy John Cobbett
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    Administrateur
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    3-5 Melville Street
    Scotland
    EnglandBritish189596740001
    SMITH, Peter David Mawby
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Administrateur
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    EnglandBritish159286600001
    TRAINER, Peter
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    27
    Scotland
    Administrateur
    Lauriston Street
    EH3 9DQ Edinburgh
    27
    Scotland
    ScotlandBritish135727620001
    VOHRA, Sam
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Administrateur
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    EnglandBritish312387440001
    VOHRA, Sameet
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    Administrateur
    Inchcorse Place
    Whitehill Industrial Estate
    EH48 2EE Bathgate
    3
    Scotland
    EnglandBritish126382440002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SURESERVE ENERGY SERVICES UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Sureserve Energy Holdings Limited
    13 Southampton Place
    WC1A 2JA London
    Norfolk House
    England
    30 juin 2016
    13 Southampton Place
    WC1A 2JA London
    Norfolk House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement09790912
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0