HUB SW NHSL SUB HUB CO LIMITED

HUB SW NHSL SUB HUB CO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHUB SW NHSL SUB HUB CO LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC458387
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HUB SW NHSL SUB HUB CO LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe HUB SW NHSL SUB HUB CO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Avondale House Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    North Lanarkshire
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de HUB SW NHSL SUB HUB CO LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HUB SW NHSL SUB HUB CO LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au19 août 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation02 sept. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au19 août 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour HUB SW NHSL SUB HUB CO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    replacement-filing-of-director-appointment-with-name

    3 pagesRP01AP01

    Nomination de Equitix Management Services Limited en tant que secrétaire le 01 nov. 2025

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Alexander William Gallon en tant que secrétaire le 01 nov. 2025

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 19 août 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Alexander William Gallon en tant que secrétaire le 11 août 2025

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Daniela Radulescu en tant que secrétaire le 11 août 2025

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Glenn Sinclair Pearce en tant que directeur le 01 juil. 2025

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2024

    25 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stewart William Small le 25 nov. 2024

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Glenn Sinclair Pearce en tant qu'administrateur le 01 oct. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Craig Bernard Young en tant que directeur le 01 juil. 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 19 août 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2023

    24 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Avondale House, Suites 1L - 1O Phoenix Crescent Strathclyde Business Park Bellshill North Lanarkshire ML4 3NJ Scotland à Avondale House Suites 1B-1E, Phoenix Crescent Strathclyde Business Park Bellshill North Lanarkshire ML4 3NJ le 06 juin 2024

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Nial Watson Gemmell en tant que directeur le 29 févr. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Ruth Mairi Hann en tant qu'administrateur le 29 févr. 2024

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    22 déc. 2025Replaced A replacement AP01 was registered on 22/12/2025.

    Cessation de la nomination de Michael Joseph Mcbrearty en tant que directeur le 22 déc. 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 19 août 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2022

    24 pagesAA

    Nomination de Mr Stewart William Small en tant qu'administrateur le 07 déc. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Glenn Sinclair Pearce en tant que directeur le 07 déc. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Dominique Julia Sclater en tant qu'administrateur le 29 août 2022

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 19 août 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2021

    30 pagesAA

    Nomination de Fraser John Bell en tant qu'administrateur le 23 févr. 2022

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de HUB SW NHSL SUB HUB CO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EQUITIX MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    3rd Floor (South)
    United Kingdom
    Secrétaire
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    3rd Floor (South)
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement06904246
    342191500001
    BELL, Fraser John
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish293016140001
    HANN, Ruth Mairi
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish289345220001
    MACKIE, William, Dr
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish90428550001
    NICOL, Alastair William
    Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    11-15
    Scotland
    Administrateur
    Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    11-15
    Scotland
    United KingdomBritish183296710001
    SCLATER, Dominique Julia
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish300730310001
    SMALL, Stewart William
    Cobalt Square
    83-85 Hagley Road
    B16 8QG Birmingham
    9th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Cobalt Square
    83-85 Hagley Road
    B16 8QG Birmingham
    9th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish302497750001
    GALLON, Alexander William
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Secrétaire
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    339010970001
    RADULESCU, Daniela
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Secrétaire
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    250198870001
    THAKRAR, Amit Rishi Jaysukh
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Secrétaire
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    215185520001
    BILL, Andrew Kerr
    Ballygowan Road
    BT26 6HX Hillsborough
    5
    County Down
    Northern Ireland
    Administrateur
    Ballygowan Road
    BT26 6HX Hillsborough
    5
    County Down
    Northern Ireland
    United KingdomBritish173800740001
    GEMMELL, Nial Watson
    Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    11-15
    Scotland
    Administrateur
    Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    11-15
    Scotland
    ScotlandBritish176999390001
    GILLIES, Donald Martin
    Wellington Square
    KA7 1DR Ayr
    County Building
    Scotland
    Administrateur
    Wellington Square
    KA7 1DR Ayr
    County Building
    Scotland
    ScotlandScottish180785420001
    GREEN, Simon David
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    United Kingdom
    Administrateur
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    United Kingdom
    United KingdomBritish164987040001
    HOPE, John Alexander
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish71318590003
    LEWIS, Catherine Victoria
    High Street, Crichton Hall
    Bankend Road
    DG1 4TG Dumfries
    Nhs Dumfries & Galloway
    Dumfries & Galloway
    Scotland
    Administrateur
    High Street, Crichton Hall
    Bankend Road
    DG1 4TG Dumfries
    Nhs Dumfries & Galloway
    Dumfries & Galloway
    Scotland
    United KingdomBritish191693250001
    LINDSAY, Derek Maxwell
    Ailsa Hospital
    Dalmellington Road
    KA6 6AB Ayr
    Greenan House
    Scotland
    Administrateur
    Ailsa Hospital
    Dalmellington Road
    KA6 6AB Ayr
    Greenan House
    Scotland
    ScotlandBritish105324200002
    MACKINLAY, Gavin William
    10-11 Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    2nd Floor Welken House
    Administrateur
    10-11 Charterhouse Square
    EC1M 6EH London
    2nd Floor Welken House
    EnglandBritish177047570001
    MCBREARTY, Michael Joseph
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish189302040001
    MCCLELLAND, John Ferguson
    45 Waterloo Street
    G2 6HS Glasgow
    Alhambra House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Waterloo Street
    G2 6HS Glasgow
    Alhambra House
    United Kingdom
    ScotlandBritish157048710001
    PARKER, Nicholas Giles Burley
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    United Kingdom
    Administrateur
    91-93 Charterhouse Street
    EC1M 6HR London
    Boundary House
    United Kingdom
    EnglandBritish134463970004
    PEARCE, Glenn Sinclair
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish176131560002
    PEARCE, Glenn Sinclair
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish176131560002
    ROSE, David
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish139557410001
    THAKRAR, Amit Rishi Jaysukh
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish292696530001
    YOUNG, Craig Bernard
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish268946520001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HUB SW NHSL SUB HUB CO LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Hub South West Scotland Limited
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    Scotland
    01 août 2016
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Partnership
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0