HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.2) LIMITED

HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.2) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.2) LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC471571
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.2) LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.2) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Foresight Group Clarence House
    131-135 George Street
    EH2 4JS Edinburgh
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.2) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HUB WEST SCOTLAND MIDCO (NO.2) LIMITED04 mars 201404 mars 2014

    Quels sont les derniers comptes de HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.2) LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.2) LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au04 mars 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation18 mars 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au04 mars 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.2) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2025

    14 pagesAA

    Nomination de Mr Stewart William Small en tant qu'administrateur le 01 avr. 2025

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 04 mars 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2024

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 04 mars 2024 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Nial Watson Gemmell en tant que directeur le 29 févr. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Ruth Mairi Hann en tant qu'administrateur le 05 mars 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Alastair William Nicol en tant qu'administrateur le 01 mars 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gordon James Shirreff en tant que directeur le 30 nov. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2023

    15 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de The Lighthouse 2nd Floor 11 Mitchell Lane Glasgow G1 3NU United Kingdom à C/O Foresight Group Clarence House 131-135 George Street Edinburgh EH2 4JS le 25 juil. 2023

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr James Thomas Lloyd en tant qu'administrateur le 20 juin 2023

    2 pagesAP01

    Notification de Blackmead Hub West Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 juin 2023

    2 pagesPSC02

    Cessation de la nomination de Bina Tailor en tant que directeur le 20 juin 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John William Dryburgh en tant que directeur le 20 juin 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard John Dixon en tant que directeur le 20 juin 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Clare Sheridan en tant que secrétaire le 20 juin 2023

    1 pagesTM02

    Cessation de Wellspring Partnership Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 juin 2023

    1 pagesPSC07

    Cessation de la nomination de Marion Grey Easton Speirs en tant que directeur le 15 juin 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 04 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard John Dixon le 26 avr. 2022

    2 pagesCH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2022

    15 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 6th Floor Merchant Exchange 20 Bell Street Glasgow G1 1LG United Kingdom à The Lighthouse 2nd Floor 11 Mitchell Lane Glasgow G1 3NU le 23 mars 2022

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 04 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Bina Tailor le 30 déc. 2021

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.2) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HANN, Ruth Mairi
    91 Haymarket Terrace
    EH12 5HE Edinburgh
    Sft, Fourth Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    91 Haymarket Terrace
    EH12 5HE Edinburgh
    Sft, Fourth Floor
    United Kingdom
    ScotlandBritish289345220001
    LLOYD, James Thomas
    9th Floor, Cobalt Square
    83-85 Hagley Road
    B16 8QG Birmingham
    Gbpartnerships Group
    England
    Administrateur
    9th Floor, Cobalt Square
    83-85 Hagley Road
    B16 8QG Birmingham
    Gbpartnerships Group
    England
    United KingdomBritish279200720001
    NICOL, Alastair William
    Fourth Floor, 91 Haymarket Terrace
    EH12 5HE Edinburgh
    The Scottish Futures Trust
    United Kingdom
    Administrateur
    Fourth Floor, 91 Haymarket Terrace
    EH12 5HE Edinburgh
    The Scottish Futures Trust
    United Kingdom
    United KingdomBritish183296710001
    SMALL, Stewart William
    Aldersgate Street
    3rd Floor, South Building
    EC1A 4HD London
    200
    United Kingdom
    Administrateur
    Aldersgate Street
    3rd Floor, South Building
    EC1A 4HD London
    200
    United Kingdom
    United KingdomBritish302497750001
    SHERIDAN, Clare
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Kent House
    United Kingdom
    Secrétaire
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Kent House
    United Kingdom
    197775900001
    ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED
    Charles Street
    CF10 2GE Cardiff
    46
    Wales
    Secrétaire
    Charles Street
    CF10 2GE Cardiff
    46
    Wales
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement4086476
    114724080001
    BADHAM, Nigel Paul
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England
    Administrateur
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England
    EnglandBritish194593210009
    BAILLIE, Andrew James
    Gartnavel Royal Hospital
    1055 Great Western Road
    G12 0XH Glasgow
    Admin Building
    United Kingdom
    Administrateur
    Gartnavel Royal Hospital
    1055 Great Western Road
    G12 0XH Glasgow
    Admin Building
    United Kingdom
    United KingdomScottish292562370001
    CAMPBELL, Colin Malcolm
    Skypark 1
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3
    United Kingdom
    Administrateur
    Skypark 1
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3
    United Kingdom
    United KingdomBritish76823200003
    CURRAN, Anthony
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3, Skypark 1
    Scotland
    Administrateur
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3, Skypark 1
    Scotland
    UkBritish204831270002
    DIXON, Richard John
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Kent House
    United Kingdom
    Administrateur
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    Kent House
    United Kingdom
    United KingdomBritish267912110017
    DREW, Richard Stephen
    Adastral Park
    IP5 3RE Ipswich
    Columba House
    England
    England
    Administrateur
    Adastral Park
    IP5 3RE Ipswich
    Columba House
    England
    England
    United KingdomBritish111864530002
    DRYBURGH, John William
    Rowan House North
    1 The Professional Quarter
    SY2 6LG Shrewsbury
    Cbsl Accountants
    Shropshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Rowan House North
    1 The Professional Quarter
    SY2 6LG Shrewsbury
    Cbsl Accountants
    Shropshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish109305470002
    ERLAM, Westley Alan
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritish279666060001
    FARLEY, George Peter
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritish123834510001
    GEMMELL, Nial Watson
    11-15 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    Scottish Futures Trust
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    11-15 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    Scottish Futures Trust
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish176999390001
    GOURLAY, Alastair Graham
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Furnival Street
    EC4A 1AB London
    10
    United Kingdom
    EnglandBritish58686920001
    HARROP, Benjamin James
    6th Floor
    W1W 3ET London
    8 Old Jewry
    Administrateur
    6th Floor
    W1W 3ET London
    8 Old Jewry
    United KingdomBritish168494030003
    HOPE, John Alexander
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3, Skypark 1
    Scotland
    Administrateur
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3, Skypark 1
    Scotland
    United KingdomBritish71318590003
    KING, James Leonard
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3, Skypark 1
    Scotland
    Administrateur
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3, Skypark 1
    Scotland
    United KingdomBritish181479290001
    LANE, David George
    St John Street
    EC1M 4EH London
    100
    United Kingdom
    Administrateur
    St John Street
    EC1M 4EH London
    100
    United Kingdom
    EnglandBritish160668630001
    LOUDON, David Wilson
    Corporate Headquarters
    Gartnavel Royal Hospital
    G12 0XH Glasgow
    Nhs Greater Glasgow & Clyde
    Scotland
    Administrateur
    Corporate Headquarters
    Gartnavel Royal Hospital
    G12 0XH Glasgow
    Nhs Greater Glasgow & Clyde
    Scotland
    ScotlandBritish205510650001
    MACDONALD, Andrew Edward Douglas
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    EnglandBritish154478030001
    MATTHEWS, William Stewart
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3, Skypark 1
    Scotland
    Administrateur
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3, Skypark 1
    Scotland
    ScotlandBritish69372990001
    MCCROSSAN, Margaret Brown Porteous
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3, Skypark 1
    Scotland
    Administrateur
    8 Elliot Place
    G3 8EP Glasgow
    Suite 7/3, Skypark 1
    Scotland
    United KingdomBritish179597170001
    OTTI, Henry
    St John Street
    EC1M 4EH London
    100
    United Kingdom
    Administrateur
    St John Street
    EC1M 4EH London
    100
    United Kingdom
    EnglandBritish259088930001
    POWELL, Andrew John
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    EnglandBritish121982700003
    RICHARDSON, Ben Peter
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomBritish206173220001
    SCENNA, Lisa
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomAustralian126881800002
    SCENNA, Lisa
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Jewry
    6th Floor
    EC2R 8DN London
    8
    England And Wales
    United Kingdom
    United KingdomAustralian126881800002
    SHIRREFF, Gordon James
    11-15 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    Scottish Futures Trust
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    11-15 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    Scottish Futures Trust
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish220299710001
    SPEIRS, Marion Grey Easton
    Gartnavel Royal Hospital
    1055 Great Western Road
    G12 0XH Glasgow
    Admin Building
    United Kingdom
    Administrateur
    Gartnavel Royal Hospital
    1055 Great Western Road
    G12 0XH Glasgow
    Admin Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish257225500001
    TAILOR, Bina
    Kent House
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    C/O Morgan Sindall Group Plc
    United Kingdom
    Administrateur
    Kent House
    14-17 Market Place
    W1W 8AJ London
    C/O Morgan Sindall Group Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritish276656960001
    TITMUS, Adam John
    St John Street
    EC1M 4EH London
    100
    United Kingdom
    Administrateur
    St John Street
    EC1M 4EH London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritish249256530001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.2) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Blackmead Hub West Limited
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Foresight Group Llp
    United Kingdom
    United Kingdom
    20 juin 2023
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Foresight Group Llp
    United Kingdom
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementRegister Of Companies For England And Wales
    Numéro d'enregistrement09801824
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    C/O Anderson Strathern
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    C/O Anderson Strathern
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc422297
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0