POLYFRAME LIVINGSTON LIMITED

POLYFRAME LIVINGSTON LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPOLYFRAME LIVINGSTON LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC492792
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de POLYFRAME LIVINGSTON LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe POLYFRAME LIVINGSTON LIMITED ?

    Adresse du siège social
    14 Grange Road Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    West Lothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de POLYFRAME LIVINGSTON LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STEVENSWOOD HOLDINGS LIMITED05 déc. 201405 déc. 2014

    Quels sont les derniers comptes de POLYFRAME LIVINGSTON LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour POLYFRAME LIVINGSTON LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Martin Linden en tant que directeur le 25 juin 2019

    1 pagesTM01

    Modifications à la charge flottante SC4927920006

    79 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC4927920004

    79 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC4927920003

    79 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC4927920002

    79 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC4927920001

    79 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC4927920005

    79 pages466(Scot)

    Inscription de la charge SC4927920006, créée le 24 déc. 2018

    61 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 05 déc. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des détails de Polyframe Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 sept. 2018

    2 pagesPSC05

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2017

    20 pagesAA

    Cessation de la nomination de John Lightowlers en tant que directeur le 03 mai 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Neil Andrew Mcgill en tant qu'administrateur le 13 avr. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr John Michael Naylor-Leyland en tant qu'administrateur le 13 avr. 2018

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Lightowlers le 10 avr. 2018

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr David Brian Leng en tant qu'administrateur le 12 mars 2018

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 05 déc. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Cessation de Stevenswood Midco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 févr. 2017

    1 pagesPSC07

    Notification de Polyframe Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 févr. 2017

    2 pagesPSC02

    Cessation de la nomination de John Michael Naylor-Leyland en tant que directeur le 11 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Alan Moore en tant que directeur le 11 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Lightowlers en tant qu'administrateur le 11 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de POLYFRAME LIVINGSTON LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROGERS, Dawn
    Gibbet Street
    HX1 4JR Halifax
    Mile Thorn Works
    West Yorkshire
    England
    Secrétaire
    Gibbet Street
    HX1 4JR Halifax
    Mile Thorn Works
    West Yorkshire
    England
    231186670001
    GILLETT, Lance Dominic
    c/o Customade Group
    Oldends Lane
    Oldends
    GL10 3RQ Stonehouse
    Oldend Hall
    England
    Administrateur
    c/o Customade Group
    Oldends Lane
    Oldends
    GL10 3RQ Stonehouse
    Oldend Hall
    England
    United KingdomBritish215616270001
    LENG, David Brian
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    Administrateur
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    EnglandBritish244390050001
    MCGILL, Neil Andrew
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    Administrateur
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    ScotlandBritish232241860001
    NAYLOR-LEYLAND, John Michael
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    Administrateur
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    EnglandBritish187144180001
    FLYNN, David Charles
    EH22 3AZ Dalkeith
    9 Strawberry Bank
    Midlothian
    United Kingdom
    Secrétaire
    EH22 3AZ Dalkeith
    9 Strawberry Bank
    Midlothian
    United Kingdom
    193227300001
    HEPBURN, Ronald Edward
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    United Kingdom
    Secrétaire
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    United Kingdom
    193227310001
    BAYLISS, Alexander
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    Administrateur
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    EnglandBritish219988910001
    FLYNN, David Charles
    EH22 3AZ Dalkeith
    9 Strawberry Bank
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    EH22 3AZ Dalkeith
    9 Strawberry Bank
    Midlothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish107007050001
    GRAHAM, Patrick
    Grange Road
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Grange Road
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish189441030001
    HEPBURN, Ronald Edward
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish1156220001
    LIGHTOWLERS, John Michael
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    Administrateur
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    United KingdomBritish111277770002
    LINDEN, Martin
    Greenhead Road
    ML2 8JH Wishaw
    105
    Scotland
    Administrateur
    Greenhead Road
    ML2 8JH Wishaw
    105
    Scotland
    ScotlandBritish128077220002
    MCGARVIE, Murray
    Grange Road
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14
    Uk
    Administrateur
    Grange Road
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14
    Uk
    ScotlandBritish194937850001
    MOORE, David Alan
    York Street
    BB7 2DL Clitheroe
    44
    England
    Administrateur
    York Street
    BB7 2DL Clitheroe
    44
    England
    EnglandBritish156725110001
    MURRAY, Duncan Mclelland
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish107459060003
    NAYLOR-LEYLAND, John Michael
    22 Cross Keys Close
    W1U 2DW London
    3rd Floor
    England
    Administrateur
    22 Cross Keys Close
    W1U 2DW London
    3rd Floor
    England
    EnglandBritish187144180001
    PEARSON, David Peter
    Grange Road
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Grange Road
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    United KingdomBritish173695630001
    STEEL, Andrew David
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    Administrateur
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14 Grange Road
    West Lothian
    EnglandBritish142266440002
    TAYLOR, Darren Wilson
    Grange Road
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14
    Uk
    Administrateur
    Grange Road
    Houstoun Industrial Estate
    EH54 5DE Livingston
    14
    Uk
    ScotlandBritish178609620001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur POLYFRAME LIVINGSTON LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Customade Group Trading Limited
    Oldends Lane
    GL10 3RQ Stonehouse
    Oldend Hall
    England
    15 févr. 2017
    Oldends Lane
    GL10 3RQ Stonehouse
    Oldend Hall
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Register
    Numéro d'enregistrement10126446
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Stevenswood Midco Limited
    Gibbet Street
    HX1 4JR Halifax
    Mylethorn Works
    England
    28 nov. 2016
    Gibbet Street
    HX1 4JR Halifax
    Mylethorn Works
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Compnay
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement10233009
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    POLYFRAME LIVINGSTON LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 24 déc. 2018
    Livré le 27 déc. 2018
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cairngorm Capital Partners I, L.P.
    Transactions
    • 27 déc. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 févr. 2019Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 15 févr. 2017
    Livré le 23 févr. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Midcap Financial (Ireland)Limited
    Transactions
    • 23 févr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 févr. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 févr. 2019Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 15 févr. 2017
    Livré le 17 févr. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • John Lightowlers
    Transactions
    • 17 févr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 févr. 2019Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 15 févr. 2017
    Livré le 17 févr. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • John Lightowlers
    Transactions
    • 17 févr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 févr. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 févr. 2019Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 15 févr. 2017
    Livré le 15 févr. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cairngorm Capital Partners LLP
    Transactions
    • 15 févr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 févr. 2019Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 15 févr. 2017
    Livré le 15 févr. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cairngorm Capital Partners LLP
    Transactions
    • 15 févr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 23 févr. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 13 févr. 2019Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0