HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.3) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.3) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC497487 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.3) LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Foresight Group Clarence House 131-135 George Street EH2 4JS Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.3) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.3) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 10 févr. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 24 févr. 2026 |
| Derni ère déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 10 févr. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.3) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2025 | 13 pages | AA | ||
Nomination de Ms Kirsty Anne Stanners en tant qu'administrateur le 07 août 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Stewart William Small en tant qu'administrateur le 01 avr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2024 | 13 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Margaret Brown Porteous Mccrossan en tant que directeur le 01 août 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Philip Keith Daws en tant que directeur le 03 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Nial Watson Gemmell en tant que directeur le 29 févr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mrs Ruth Mairi Hann en tant qu'administrateur le 05 mars 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Alastair William Nicol en tant qu'administrateur le 01 mars 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2024 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Gordon James Shirreff en tant que directeur le 30 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2023 | 14 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de The Lighthouse 2nd Floor 11 Mitchell Lane Glasgow G1 3NU United Kingdom à C/O Foresight Group Clarence House 131-135 George Street Edinburgh EH2 4JS le 25 juil. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Cessation de la nomination de Bina Tailor en tant que directeur le 20 juin 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Notification de Blackmead Hub West Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 juin 2023 | 2 pages | PSC02 | ||
Nomination de Mr James Thomas Lloyd en tant qu'administrateur le 20 juin 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Richard John Dixon en tant que directeur le 20 juin 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Clare Sheridan en tant que secrétaire le 20 juin 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de Wellspring Partnership Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 juin 2023 | 1 pages | PSC07 | ||
Déclaration de confirmation établie le 10 févr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard John Dixon le 26 avr. 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2022 | 14 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Margaret Brown Porteous Mccrossan le 21 mars 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 6th Floor Merchant Exchange 20 Bell Street Glasgow G1 1LG United Kingdom à The Lighthouse 2nd Floor 11 Mitchell Lane Glasgow G1 3NU le 23 mars 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Qui sont les dirigeants de HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.3) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANN, Ruth Mairi | Administrateur | 91 Haymarket Terrace EH12 5HE Edinburgh Sft, Fourth Floor United Kingdom | Scotland | British | 289345220001 | |||||
| LLOYD, James Thomas | Administrateur | Clarence House 131-135 George Street EH2 4JS Edinburgh C/O Foresight Group United Kingdom | United Kingdom | British | 279200720001 | |||||
| NICOL, Alastair William | Administrateur | Fourth Floor, 91 Haymarket Terrace EH12 5HE Edinburgh The Scottish Futures Trust United Kingdom | United Kingdom | British | 183296710001 | |||||
| SMALL, Stewart William | Administrateur | Aldersgate Street 3rd Floor, South Building EC1A 4HD London 200 United Kingdom | United Kingdom | British | 302497750001 | |||||
| STANNERS, Kirsty Anne | Administrateur | Eastwood Park Rouken Glen Road G76 7NP Giffnock East Renfrewshire Council Hq United Kingdom | Scotland | British | 327933660001 | |||||
| SHERIDAN, Clare | Secrétaire | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House United Kingdom | 197573680001 | |||||||
| ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | Secrétaire | Charles Street CF10 2GE Cardiff 46 United Kingdom | 114724080001 | |||||||
| BADHAM, Nigel Paul | Administrateur | Old Jewry 6th Floor EC2R 8DN London 8 England And Wales United Kingdom | England | British | 194593210009 | |||||
| BADHAM, Nigel Paul | Administrateur | 6th Floor W1W 3ET London 8 Old Jewry | England | British | 132387750002 | |||||
| CAMPBELL, Colin Malcolm | Administrateur | Skypark 1 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Suite 7/3 United Kingdom | United Kingdom | British | 76823200003 | |||||
| CURRAN, Anthony | Administrateur | Jb Russell House, Gartnavel Royal Hospital Campus 1055 Great Western Road G12 0XH Glasgow C/O Greater Glasgow Health Board United Kingdom | Uk | British | 204831270002 | |||||
| DAWS, Philip Keith | Administrateur | 211 Main Street G78 2SY Barrhead East Renfrewshire Council Glasgow United Kingdom | United Kingdom | British | 293257210001 | |||||
| DIXON, Richard John | Administrateur | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Kent House United Kingdom | United Kingdom | British | 267912110017 | |||||
| DREW, Richard Stephen | Administrateur | Adastral Park IP5 3RE Ipswich Columba House England England | United Kingdom | British | 111864530001 | |||||
| DRYBURGH, John William | Administrateur | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Suite 7/3, Skypark 1 Scotland | United Kingdom | British | 109305470002 | |||||
| ERLAM, Westley Alan | Administrateur | Old Jewry 6th Floor EC2R 8DN London 8 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 279666060001 | |||||
| FARLEY, George Peter | Administrateur | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Suite 7/3, Skypark 1 Scotland | England | British | 123834510001 | |||||
| GEMMELL, Nial Watson | Administrateur | 11-15 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh Scottish Futures Trust Scotland Scotland | Scotland | British | 176999390001 | |||||
| GOURLAY, Alastair Graham | Administrateur | 6th Floor W1W 3ET London 8 Old Jewry | England | British | 58686920001 | |||||
| HARROP, Benjamin James | Administrateur | 6th Floor W1W 3ET London 8 Old Jewry | United Kingdom | British | 168494030003 | |||||
| HOPE, John Alexander | Administrateur | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Suite 7/3, Skypark 1 Scotland | United Kingdom | British | 71318590003 | |||||
| KING, James Leonard | Administrateur | 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Suite 7/3, Skypark 1 Scotland | United Kingdom | British | 181479290001 | |||||
| LANE, David George | Administrateur | St John Street EC1M 4EH London 100 United Kingdom | England | British | 160668630001 | |||||
| MACDONALD, Andrew Edward Douglas | Administrateur | Old Jewry 6th Floor EC2R 8DN London 8 England And Wales United Kingdom | England | British | 154478030001 | |||||
| MATTHEWS, William Stewart | Administrateur | Skypark 1 8 Elliot Place G3 8EP Glasgow Suite 7/3 United Kingdom | Scotland | British | 69372990001 | |||||
| MCCROSSAN, Margaret Brown Porteous | Administrateur | Clarence House 131-135 George Street EH2 4JS Edinburgh C/O Foresight Group United Kingdom | United Kingdom | British | 179597170001 | |||||
| O'KANE, Raymond | Administrateur | C/O Council Headquarters, Eastwood Park Roukenglen Road G46 6UG Giffnock Property And Technical Services Scotland | Scotland | British | 206174290001 | |||||
| OTTI, Henry | Administrateur | St John Street EC1M 4EH London 100 United Kingdom | England | British | 259088930001 | |||||
| POWELL, Andrew John | Administrateur | Old Jewry 6th Floor EC2R 8DN London 8 England And Wales United Kingdom | England | British | 121982700003 | |||||
| RICHARDSON, Ben Peter | Administrateur | Old Jewry 6th Floor EC2R 8DN London 8 England | United Kingdom | British | 206173220001 | |||||
| SCENNA, Lisa | Administrateur | Old Jewry 6th Floor EC2R 8DN London 8 England And Wales United Kingdom | United Kingdom | Australian | 126881800002 | |||||
| SHIRREFF, Gordon James | Administrateur | 11-15 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh Scottish Futures Trust Scotland Scotland | United Kingdom | British | 220299710001 | |||||
| TAILOR, Bina | Administrateur | Kent House 14-17 Market Place W1W 8AJ London C/O Morgan Sindall Group Plc United Kingdom | United Kingdom | British | 276656960001 | |||||
| TITMUS, Adam John | Administrateur | St John Street EC1M 4EH London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 249256530001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HUB WEST SCOTLAND HOLDCO (NO.3) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackmead Hub West Limited | 20 juin 2023 | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London C/O Foresight Group Llp United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Wellspring Partnership Limited | 06 avr. 2016 | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh C/O Anderson Strathern United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0