HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED

HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC506019
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Avondale House Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    North Lanarkshire
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HUB SW DALBEATTIE SUB HUB CO LIMITED15 mai 201515 mai 2015

    Quels sont les derniers comptes de HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au15 mai 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation29 mai 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au15 mai 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    replacement-filing-of-director-appointment-with-name

    3 pagesRP01AP01

    Cessation de la nomination de Colin John Freeman en tant que directeur le 25 nov. 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Kevin Alistair Cunningham en tant qu'administrateur le 23 oct. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alexander William Gallon en tant que secrétaire le 01 nov. 2025

    1 pagesTM02

    Nomination de Equitix Management Services Limited en tant que secrétaire le 01 nov. 2025

    2 pagesAP04

    Nomination de Mr Alexander William Gallon en tant que secrétaire le 06 août 2025

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Daniela Radulescu en tant que secrétaire le 06 août 2025

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Glenn Sinclair Pearce en tant que directeur le 01 juil. 2025

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2024

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stewart William Small le 25 nov. 2024

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Glenn Sinclair Pearce en tant qu'administrateur le 01 oct. 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Colin John Freeman en tant qu'administrateur le 18 juil. 2024

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Craig Bernard Young en tant que directeur le 01 juil. 2024

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2023

    22 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Avondale House, Suites 1L - 1O Phoenix Crescent Strathclyde Business Park Bellshill North Lanarkshire ML4 3NJ Scotland à Avondale House Suites 1B-1E, Phoenix Crescent Strathclyde Business Park Bellshill North Lanarkshire ML4 3NJ le 06 juin 2024

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Paul Mcculloch en tant que directeur le 15 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nial Watson Gemmell en tant que directeur le 29 févr. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Ruth Mairi Hann en tant qu'administrateur le 29 févr. 2024

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    18 déc. 2025Replaced A replacement AP01 was registered on 18/12/2025.

    Cessation de la nomination de Michael Joseph Mcbrearty en tant que directeur le 22 déc. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2022

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Glenn Sinclair Pearce en tant que directeur le 07 déc. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stewart William Small en tant qu'administrateur le 07 déc. 2022

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EQUITIX MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    3rd Floor (South)
    United Kingdom
    Secrétaire
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    3rd Floor (South)
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement06904246
    342191500001
    AGOUN, Mohammed Ilies
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish299696770001
    CUNNINGHAM, Kevin Alistair
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish271263600001
    HANN, Ruth Mairi
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish289345220001
    NICOL, Alastair William
    Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    11 - 15
    Scotland
    Administrateur
    Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    11 - 15
    Scotland
    United KingdomBritish183296710001
    SMALL, Stewart William
    Cobalt Square
    83-85 Hagley Road
    B16 8QG Birmingham
    9th Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    Cobalt Square
    83-85 Hagley Road
    B16 8QG Birmingham
    9th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish302497750001
    GALLON, Alexander William
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Secrétaire
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    338856880001
    RADULESCU, Daniela
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Secrétaire
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    250188520001
    THAKRAR, Amit Rishi Jaysukh
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Secrétaire
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    199927520001
    BILL, Andrew Kerr
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Northern IrelandBritish135805560001
    FAIRBANK, Graham Bruce
    Tempsford Hall
    Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Tempsford Hall
    Sandy
    Tempsford Hall
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish153133930001
    FREEMAN, Colin John
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish326812390001
    GEMMELL, Nial Watson
    Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    11-15
    Scotland
    Administrateur
    Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    11-15
    Scotland
    ScotlandBritish176999390001
    HOPE, John Alexander
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish71318590003
    LEWIS, Catherine Victoria
    Bankend Road
    High West
    DG1 4TG Crichton Hall
    Nhs Dumfries And Galloway
    Dumfries
    United Kingdom
    Administrateur
    Bankend Road
    High West
    DG1 4TG Crichton Hall
    Nhs Dumfries And Galloway
    Dumfries
    United Kingdom
    United KingdomBritish191693250001
    LINDSAY, Derek Maxwell
    Barns Park
    KA7 2AH Ayr
    2
    Scotland
    Administrateur
    Barns Park
    KA7 2AH Ayr
    2
    Scotland
    United KingdomScottish200206490001
    MACKINLAY, Gavin William
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    EnglandBritish177047570001
    MCBREARTY, Michael Joseph
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish189302040001
    MCCLELLAND, John Ferguson
    Strathclyde Business Park
    Kestrel View
    ML4 3PB Bellshill
    Suite 1a, Willow House
    Lanarkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Strathclyde Business Park
    Kestrel View
    ML4 3PB Bellshill
    Suite 1a, Willow House
    Lanarkshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish157048710001
    MCCULLOCH, Paul
    Cargen Tower
    Garroch Business Park
    DG2 8PN Garroch Loaning
    Corporate Services, Dumfries And Galloway Council
    Dumfries
    Scotland
    Administrateur
    Cargen Tower
    Garroch Business Park
    DG2 8PN Garroch Loaning
    Corporate Services, Dumfries And Galloway Council
    Dumfries
    Scotland
    ScotlandBritish254134750001
    PARKER, Nicholas Giles Burley
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    EnglandBritish134463970004
    PEARCE, Glenn Sinclair
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish176131560002
    PEARCE, Glenn Sinclair
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish176131560002
    RENTON, Claire
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish209041240001
    ROSE, David
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish139557410001
    THAKRAR, Amit Rishi Jaysukh
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    North Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritish292696530001
    YOUNG, Craig Bernard
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Suites 1b-1e, Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House
    North Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritish268946520001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HUB SW DALBEATTIE DBFM CO LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Hub Sw Dalbeattie Holdco Limited
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    Scotland
    15 mai 2017
    Phoenix Crescent
    Strathclyde Business Park
    ML4 3NJ Bellshill
    Avondale House, Suites 1l - 1o
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Partnership
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0