Andrew Stuart MCLEAN
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Andrew |
Deuxième prénom | Stuart |
Nom de famille | MCLEAN |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 1 |
Inactif | 12 |
Démissionné | 48 |
Total | 61 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEC CONSTRUCTION LIMITED | 11 août 2020 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Booths Park Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Cheshire | Scotland | British | |
JAMES SCOTT ENGINEERING GROUP LIMITED | 11 août 2020 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen Ground Floor, 15 Scotland | Scotland | British | |
AMEC MINING LIMITED | 11 août 2020 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire | Scotland | British | |
AMEC OFFSHORE DEVELOPMENTS LIMITED | 11 août 2020 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen Ground Floor, 15 Scotland | Scotland | British | |
AMEC (BCS) LIMITED | 11 août 2020 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire | Scotland | British | |
UK NUCLEAR RESTORATION LIMITED | 06 mai 2020 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British | |
AMEC NUCLEAR OVERSEAS LIMITED | 06 mars 2020 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British | |
WOOD GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 10 déc. 2019 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British | |
KELWAT INVESTMENTS LIMITED | 09 déc. 2019 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British | |
AMEC FOSTER WHEELER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 09 déc. 2019 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British | |
WGD028 LIMITED | 09 déc. 2019 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British | |
MDM UK FINANCE LIMITED | 09 déc. 2019 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British | |
SSL HEALTHCARE MANUFACTURING S.A. | 02 janv. 2008 | Active | Secrétaire | 57 Linden Park Burnage M19 2PG Manchester Lancashire | British | |||
PRESS CONSTRUCTION LIMITED | 11 août 2020 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British |
AMEC PROCESS AND ENERGY LIMITED | 11 août 2020 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British |
AMEC BKW LIMITED | 11 août 2020 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | Scotland | British |
AMEC SERVICES LIMITED | 11 août 2020 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British |
PROCESS PLANTS SUPPLIERS LIMITED | 11 août 2020 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British |
JAMES SCOTT LIMITED | 11 août 2020 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British |
AMEC (WSL) LIMITED | 11 août 2020 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | Scotland | British |
AMEC (MHL) LIMITED | 11 août 2020 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | Scotland | British |
AMEC (F.C.G.) LIMITED | 11 août 2020 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | Scotland | British |
AMEC BUILDING LIMITED | 11 août 2020 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire | Scotland | British |
AMEC OFFSHORE LIMITED | 11 août 2020 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Booths Park Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Cheshire | Scotland | British |
AMEC CIVIL ENGINEERING LIMITED | 11 août 2020 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Booths Park Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Cheshire | Scotland | British |
AMEC PROJECT INVESTMENTS LIMITED | 11 août 2020 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British |
AMEC CAPITAL PROJECTS LIMITED | 11 août 2020 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British |
FOSTER WHEELER UK INVESTMENTS LIMITED | 18 déc. 2019 | 31 août 2024 | Active | Director | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 United Kingdom | Scotland | British |
JWGUSA HOLDINGS LIMITED | 10 déc. 2019 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British |
WOOD LIMITED | 09 déc. 2019 | 31 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British |
AMEC INVESTMENTS EUROPE LIMITED | 11 août 2020 | 22 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British |
FOSTER WHEELER ENVIRONMENTAL (UK) LIMITED | 11 août 2020 | 22 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British |
FOSTER WHEELER (PROCESS PLANTS) LIMITED | 11 août 2020 | 22 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British |
METAL AND PIPELINE ENDURANCE LIMITED | 11 août 2020 | 22 août 2024 | Active | Company Director | Administrateur | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British |
AMEC FOSTER WHEELER EARTH AND ENVIRONMENTAL (UK) LIMITED | 18 déc. 2019 | 22 août 2024 | Dissoute | Company Director | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0