AMEC OFFSHORE DEVELOPMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | AMEC OFFSHORE DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC137017 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe AMEC OFFSHORE DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Ground Floor, 15 Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de AMEC OFFSHORE DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour AMEC OFFSHORE DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 4 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 08 sept. 2020
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomination de Mr Andrew Stuart Mclean en tant qu'administrateur le 11 août 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Amec Nominees Limited en tant que directeur le 11 août 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
État du capital au 02 juil. 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Statuts | 30 pages | MA | ||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions | 2 pages | SH08 | ||||||||||||||
Détails de la variation des droits attachés aux actions | 3 pages | SH10 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de AMEC OFFSHORE DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Iain Angus | Secrétaire | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen Ground Floor, 15 Scotland | 243965680001 | |||||||||||
| MCLEAN, Andrew Stuart | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen Ground Floor, 15 Scotland | Scotland | British | 262737780001 | |||||||||
| WATSON, Mark James | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen Ground Floor, 15 Scotland | Scotland | British | 131162300002 | |||||||||
| FELLOWES, Colin | Secrétaire | 9 Thistlewood Drive Summerfields SK9 2RF Wilmslow Cheshire | British | 800670001 | ||||||||||
| FIDLER, Christopher Laskey | Secrétaire | Marlborough Avenue SK8 7AW Cheadle Hulme 66 Cheshire | British | 141025870003 | ||||||||||
| HAND, Kim Andrea | Secrétaire | Sutton Field Whitegate CW8 2BD Northwich Cherry Trees, Cheshire | British | 141032930001 | ||||||||||
| MORRELL, Helen | Secrétaire | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire England | 203307710001 | |||||||||||
| WARBURTON, Jennifer Ann | Secrétaire | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | 225602730001 | |||||||||||
| BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001550001 | |||||||||||
| BARDSLEY, Michael John | Administrateur | 7 Downs End WA16 8BQ Knutsford Cheshire England | British | 34847060001 | ||||||||||
| CLARK, Alexander | Administrateur | 240 Queens Road AB1 8DN Aberdeen | United Kingdom | British | 136094220002 | |||||||||
| CLARK, Dennis | Administrateur | Flat B 65 Eaton Square SW1W 9BQ London | British | 45617820001 | ||||||||||
| DAVIES, Nigel James Maxwell | Administrateur | Castle Hill Waste Lane Kelsall CW6 0PE Tarporley Cheshire | British | 830730002 | ||||||||||
| FIDLER, Christopher Laskey | Administrateur | Marlborough Avenue SK8 7AW Cheadle Hulme 66 Cheshire | England | British | 141025870003 | |||||||||
| HAUXWELL, Barry Anthony | Administrateur | Little Gatton Abergeldie Road Ballater | British | 45049560002 | ||||||||||
| HOLLAND, Peter James | Administrateur | Woodside House Wynnstay Lane, Marford LL12 8LH Wrexham | Wales | British | 75624260001 | |||||||||
| LINDEMAN, Dennis | Administrateur | 16 Bovinger Way Thorpe Bay SS1 3SZ Southend On Sea Essex | British | 11712860001 | ||||||||||
| MANNING, David Ernest George | Administrateur | 89 Jesmond Park West NE7 7BY Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 11712890001 | |||||||||
| MILLER, Graham Edwin | Administrateur | 64 Greenend Street Aston Clinton HP22 5EU Aylesbury Buckinghamshire | British | 34666120001 | ||||||||||
| ORRELL, Colin Stewart | Administrateur | Woodside View Victoria Road Modest Corner Southborough TN4 0LT Tunbridge Wells Kent | British | 36507600001 | ||||||||||
| ROBSON, David | Administrateur | Milling Field House 1 The Milling Field Holmes Chapel CW4 7DA Crewe Cheshire | British | 36329960001 | ||||||||||
| RUSTAM, Shahrokh Sohrab | Administrateur | 29 Westbury Road HA6 3DB Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 19305510001 | |||||||||
| STRAUGHEN, Michael | Administrateur | 68 Rubislaw Den North AB15 4AN Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | 68935280002 | |||||||||
| STRAUGHEN, Michael | Administrateur | 6 Oldfold Drive Milltimber AB1 0JZ Aberdeen Aberdeenshire | British | 68935280001 | ||||||||||
| TURNER, Ronald Frederick | Administrateur | Taneys Dell Heath Park Road LU7 3BB Leighton Buzzard Bedfordshire | England | British | 26086190002 | |||||||||
| WARBURTON, Jennifer Ann | Administrateur | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire England | United Kingdom | British | 210947760001 | |||||||||
| AMEC NOMINEES LIMITED | Administrateur | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park Cheshire |
| 32732300002 | ||||||||||
| DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED | Administrateur désigné | The Britannia Suite International House 82-86 Deansgate M3 2ER Manchester | 900001540001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AMEC OFFSHORE DEVELOPMENTS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amec Foster Wheeler Limited | 06 avr. 2016 | Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Booths Park England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0