GRANTS SCOTLAND LIMITED - Page 4
Dirigeant de société
Nom | GRANTS SCOTLAND LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 4 |
Inactif | 102 |
Démissionné | 58 |
Total | 164 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
WHITEINCH LIMITED | 28 août 2003 | Dissoute | Secrétaire | Centrum House 38 Queen Street G1 3DX Glasgow 6th Floor | |
AFW TECHNICAL CONSULTING LIMITED | 25 févr. 2011 | 06 avr. 2024 | Active | Secrétaire | West Regent Street 5th Floor G2 2QD Glasgow 120 Scotland |
SUNSIDE LIMITED | 05 mars 2009 | 31 mars 2022 | Active | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
ARRANVIEW LIMITED | 10 juil. 2009 | 15 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
BARBES CONSULTING LIMITED | 05 mai 2006 | 12 oct. 2019 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
RMH (EDINBURGH) LIMITED | 09 mai 2007 | 29 août 2019 | Dissoute | Secrétaire | . 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House Scotland |
METHVEN COMPUTING LIMITED | 12 avr. 2007 | 05 juil. 2019 | Dissoute | Secrétaire | 68 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House Scotland |
BONVIEW LIMITED | 03 janv. 2007 | 18 juin 2019 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
GROVEMANSE LIMITED | 05 juil. 2004 | 02 juin 2019 | Active | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
4BIT CONSULTING LIMITED | 10 févr. 2010 | 29 mai 2019 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
MCLARNONWORLD LIMITED | 21 nov. 2006 | 21 mai 2019 | Active | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
ISLEBAY LIMITED | 09 mars 2004 | 20 mai 2019 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
AJ MACLACHLAN CONSULTING LIMITED | 10 janv. 2012 | 30 avr. 2019 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
AKASHA EDINBURGH LIMITED | 29 janv. 2007 | 19 avr. 2019 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
ASSETREAL LIMITED | 30 sept. 2005 | 21 févr. 2019 | Active | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House Scotland |
GSEVEN8 LTD. | 20 sept. 2006 | 25 janv. 2018 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House Scotland |
AHT SOLUTIONS LIMITED | 02 avr. 2007 | 29 nov. 2017 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
MUIR SOLUTIONS LIMITED | 04 juil. 2013 | 27 nov. 2017 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
OAKCREW LIMITED | 27 févr. 2007 | 22 déc. 2014 | Active | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
BROOKS REYNOLDS LTD. | 20 janv. 2009 | 30 avr. 2014 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
MAYETECH LIMITED | 19 août 2005 | 28 févr. 2014 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
MACKINNON SOLUTIONS LIMITED | 13 déc. 2011 | 07 oct. 2013 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
ACREDOVE LIMITED | 26 mai 2009 | 04 oct. 2013 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
HAMILTON LEWIS LIMITED | 03 mai 2004 | 02 août 2013 | Dissoute | Secrétaire | 69 West Nile Street G1 2QB Glasgow Moncrieff House United Kingdom |
JMBR LTD | 09 févr. 2007 | 01 févr. 2013 | Dissoute | Secrétaire | Floor, Centrum Offices 38 Queen Street G1 3DX Glasgow 6th United Kingdom |
STONEY CREEK CONSULTING LIMITED | 07 déc. 2005 | 02 août 2012 | Dissoute | Secrétaire | Floor Centrum House 38 Queen Street G1 3DX Glasgow 6th United Kingdom |
BCAA LIMITED | 09 déc. 2010 | 10 mai 2012 | Dissoute | Secrétaire | 38 Queen Street G1 3DX Glasgow Centrum Offices United Kingdom |
SIXTYSEVENPROJECTS LIMITED | 30 juil. 2003 | 01 juil. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Floor Centrum House 38 Queen Street G1 3DX Glasgow 6th United Kingdom |
I.B. CONSULTANCY LIMITED | 17 sept. 2004 | 01 avr. 2011 | Active | Secrétaire | Centrum House 38 Queen Street G1 3DX Glasgow 6th Floor |
GLENCROSS CONSULTING LTD | 27 sept. 2006 | 30 sept. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Floor Centrum House 38 Queen Street G1 3DX Glasgow 6th Scotland |
G. BAKER LIMITED | 25 juil. 2006 | 25 juil. 2010 | Dissoute | Secrétaire | Queen Street 6th Floor, Centrum House G1 3DX Glasgow 38 |
CRUNIVUS LTD. | 30 mars 2005 | 06 avr. 2009 | Dissoute | Secrétaire | Centrum House 38 Queen Street G1 3DX Glasgow 6th Floor |
C&PM SERVICES LTD. | 13 juin 2007 | 01 mars 2009 | Dissoute | Secrétaire | Queen Street 6th Floor, Centrum House G1 3DX Glasgow 38 |
GAZELLE GROUP LTD. | 07 juil. 2008 | 24 juil. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Centrum House 38 Queen Street G1 3DX Glasgow 6th Floor |
LAKEBREEZE LIMITED | 18 juin 2008 | 24 juil. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Centrum House 38 Queen Street G1 3DX Glasgow 6th Floor |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0