John David Taylor GREIG
Personne physique
| Titre | Mr |
|---|---|
| Prénom | John |
| Deuxième prénom | David Taylor |
| Nom de famille | GREIG |
| Date de naissance | |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 1 |
| Démissionné | 35 |
| Total | 36 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGH TREES SERVICES (UK) LIMITED | 30 juin 2014 | Dissoute | Administrateur | South Croxted Road SE21 8AZ London 21 England | England | British | ||
| DEFENCE SCS LIMITED | 04 avr. 2008 | 01 juin 2014 | Dissoute | Secrétaire | Devonport Royal Dockyard Devonport PL1 4SG Plymouth Devon | Other | ||
| APPLEDORE SHIPBUILDERS (2004) LIMITED | 01 avr. 2008 | 01 juin 2014 | Active | Secrétaire | Devonport Royal Dockyard Devonport Plymouth Pl1 4sg | Other | ||
| DEVONPORT ROYAL DOCKYARD LIMITED | 01 avr. 2008 | 01 juin 2014 | Active | Secrétaire | Devonport Royal Dockyard Devonport PL1 4SG Plymouth | Other | ||
| BABCOCK MARINE (DEVONPORT) LIMITED | 01 avr. 2008 | 01 juin 2014 | Active | Secrétaire | C/O Devonport Royal Dockyard Ltd Devonport PL1 4SG Plymouth | Other | ||
| BABCOCK MARINE (ROSYTH) LIMITED | 24 janv. 2008 | 01 juin 2014 | Active | Secrétaire | Rosyth KY11 2YD Dunfermline Rosyth Business Park Fife Scotland | Other | ||
| FBM BABCOCK MARINE HOLDINGS (UK) LIMITED | 14 oct. 2004 | 01 juin 2014 | Active | Secrétaire | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
| BNS PENSIONS LIMITED | 28 août 2002 | 01 juin 2014 | Active | Secrétaire | c/o Babcock International Group Rosyth KY11 2YD Dunfermline Rosyth Business Park Fife Scotland | Other | ||
| MARINE ENGINEERING & FABRICATIONS LIMITED | 02 août 2002 | 01 juin 2014 | Active | Secrétaire | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
| MARINE ENGINEERING & FABRICATIONS (HOLDINGS) LIMITED | 02 août 2002 | 01 juin 2014 | Liquidation | Secrétaire | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
| BABCOCK MARINE (CLYDE) LIMITED | 07 août 2001 | 01 juin 2014 | Active | Secrétaire | Rosyth KY11 2YD Dunfermline Rosyth Business Park Fife | Other | ||
| BABCOCK MANAGEMENT 2019 LIMITED | 06 mars 2001 | 01 juin 2014 | Liquidation | Secrétaire | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
| FBM BABCOCK MARINE LIMITED | 03 nov. 2000 | 01 juin 2014 | Active | Secrétaire | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
| FBV DESIGNS LIMITED | 21 juin 2000 | 01 juin 2014 | Dissoute | Secrétaire | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
| BABCOCK DEFENCE SYSTEMS LIMITED | 16 mai 2000 | 01 juin 2014 | Active | Secrétaire | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
| ROSYTH ROYAL DOCKYARD LIMITED | 28 avr. 2000 | 01 juin 2014 | Active | Secrétaire | c/o Babcock International Rosyth KY11 2YD Dunfermline Rosyth Business Park Fife Scotland | Other | ||
| ARMSTRONG TECHNOLOGY ASSOCIATES LIMITED | 27 janv. 2000 | 01 juin 2014 | Active | Secrétaire | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
| BABCOCK DS 2019 LIMITED | 01 avr. 1997 | 01 juin 2014 | Liquidation | Secrétaire | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | Other | ||
| BABCOCK DESIGN & TECHNOLOGY LIMITED | 10 mars 1997 | 01 juin 2014 | Active | Secrétaire | Rosyth Business Park Rosyth KY11 2YD Dunfermline Fife | Other | ||
| PORT BABCOCK ROSYTH LIMITED | 10 mars 1997 | 01 juin 2014 | Active | Secrétaire | Rosyth Business Park Rosyth KY11 2YD Dunfermline Fife | Other | ||
| ROSYTH ROYAL DOCKYARD PENSION TRUSTEES LIMITED | 28 févr. 2001 | 15 mars 2013 | Active | Administrateur | c/o C/O Babcock International Group Rosyth KY11 2YD Dunfermline Rosyth Business Park Fife | England | British | |
| BNS PENSION TRUSTEES LIMITED | 21 juin 1999 | 01 mai 2012 | Active | Secrétaire | c/o Babcock International Group Rosyth KY11 2YD Dunfermline Rosyth Business Park Fife Scotland | Other | ||
| ROSYTH ROYAL DOCKYARD PENSION TRUSTEES LIMITED | 31 mai 2000 | 01 août 2011 | Active | Secrétaire | c/o C/O Babcock International Group Rosyth KY11 2YD Dunfermline Rosyth Business Park Fife | Other | ||
| BABCOCK SUPPORT SERVICES LIMITED | 28 avr. 2000 | 03 juin 2011 | Active | Secrétaire | Dalmore House 310 St Vincent Street G2 5QR Glasgow C/O Biggart Baillie Llp Scotland Scotland | Other | ||
| FMA SERVICES LIMITED | 17 mai 2006 | 15 mai 2009 | Dissoute | Secrétaire | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
| AIR POWER INTERNATIONAL LIMITED | 29 janv. 2001 | 14 avr. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
| BABCOCK AIRPORTS LIMITED | 17 mai 2006 | 16 janv. 2009 | Active | Secrétaire | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
| BABCOCK SERVICES GROUP LIMITED | 17 mai 2006 | 16 janv. 2009 | Active | Secrétaire | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
| CAVENDISH NUCLEAR LIMITED | 17 mai 2006 | 16 janv. 2009 | Active | Secrétaire | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
| ALSTEC AUTOMATION LIMITED | 17 mai 2006 | 16 janv. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
| ALSTEC DEFENCE LIMITED | 17 mai 2006 | 16 janv. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
| BABCOCK POWER MAINTENANCE LIMITED | 17 mai 2006 | 16 janv. 2009 | Dissoute | Secrétaire | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
| CMR CONSULTANTS LIMITED | 10 févr. 2000 | 01 mars 2004 | Active | Secrétaire | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
| ENER-G SERVICES CO LIMITED | 10 févr. 2000 | 01 mars 2004 | Dissoute | Secrétaire | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other | ||
| ROSYTH REGENERATION LIMITED | 11 août 1997 | 10 avr. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 29 Howe Street EH3 6TF Edinburgh | Other |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0