ROSYTH REGENERATION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROSYTH REGENERATION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC152258
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROSYTH REGENERATION LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ROSYTH REGENERATION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    MAZARS LLP
    90 St. Vincent Street
    G2 5UB Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ROSYTH REGENERATION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ROSYTH 2000 LIMITED23 sept. 199423 sept. 1994
    RANDOTTE (NO. 345) LIMITED02 août 199402 août 1994

    Quels sont les derniers comptes de ROSYTH REGENERATION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 févr. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ROSYTH REGENERATION LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ROSYTH REGENERATION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de * 93 George Street Edinburgh EH2 3ES* le 26 sept. 2012

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 août 2012

    État du capital au 20 août 2012

    • Capital: GBP 1,000,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 févr. 2012

    5 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2011

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Simon Charles Mccabe en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ivan Goldberg en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    4 pagesMG03s

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Esplanade Director Limited le 02 août 2010

    2 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Esplanade Secretarial Services Limited le 02 août 2010

    2 pagesCH04

    Comptes pour une société dormante établis au 28 févr. 2010

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 4a Melville Street Edinburgh EH3 7NS United Kingdom* le 15 mars 2010

    2 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2009

    13 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ivan Anthony Goldberg le 01 oct. 2009

    3 pagesCH01

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    3 pages288a

    Comptes annuels établis au 29 févr. 2008

    14 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages353

    Qui sont les dirigeants de ROSYTH REGENERATION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Secrétaire
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6133270
    123430250001
    MCCABE, Simon Charles
    St. Vincent Street
    G2 5UB Glasgow
    90
    Administrateur
    St. Vincent Street
    G2 5UB Glasgow
    90
    EnglandBritish162929290001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement6133267
    123430390001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Secrétaire
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    British1267050001
    GREIG, John David Taylor
    29 Howe Street
    EH3 6TF Edinburgh
    Secrétaire
    29 Howe Street
    EH3 6TF Edinburgh
    Other51884660001
    KENNEDY, Andrew Patrick
    12 Torphin Bank
    Colinton
    EH13 0PH Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    12 Torphin Bank
    Colinton
    EH13 0PH Edinburgh
    Midlothian
    British591490002
    MCCABE, Sandra
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    Secrétaire
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    The White House
    North Yorkshire
    British920260005
    MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell
    14 Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    Secrétaire désigné
    14 Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    British900003350001
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Secrétaire
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    BATTY, David Stewart
    10 Bowling Green Road
    EH29 9BG Kirkliston
    West Lothian
    Administrateur
    10 Bowling Green Road
    EH29 9BG Kirkliston
    West Lothian
    United KingdomBritish25024920003
    BERRY, Charles Andrew
    5 Grange Road
    Bearsden
    G61 3PL Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    5 Grange Road
    Bearsden
    G61 3PL Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish109780690001
    CLARKE, David Michael
    2 Garyvard
    Main Street, Buchlyvie
    FK8 3LR Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    2 Garyvard
    Main Street, Buchlyvie
    FK8 3LR Stirling
    Stirlingshire
    British68170950001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    EASTON, Murray Simpson
    7 Cromalt Crescent North Baljaffray
    Bearsden
    G61 4RX Glasgow
    Administrateur
    7 Cromalt Crescent North Baljaffray
    Bearsden
    G61 4RX Glasgow
    British52962730001
    FLEMING, Alistair
    Mayfield 8 Erskine Road
    Giffnock
    G46 6TQ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Mayfield 8 Erskine Road
    Giffnock
    G46 6TQ Glasgow
    Lanarkshire
    British1359650001
    GOLDBERG, Ivan Anthony
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United KingdomBritish133676040001
    LANDELS, William Daniel
    41 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6SD Glasgow
    Administrateur
    41 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6SD Glasgow
    British40909860001
    LINDSAY, Douglas Wallace
    60 Muirs
    KY13 8AU Kinross
    Perth & Kinross
    Administrateur
    60 Muirs
    KY13 8AU Kinross
    Perth & Kinross
    British69982090001
    MACPHERSON, Alexander Allan
    Barns Khowe
    Old Sauchie Sauchieburn
    FK7 9QE Stirling
    Administrateur
    Barns Khowe
    Old Sauchie Sauchieburn
    FK7 9QE Stirling
    British40967800001
    MASTERTON, Gavin George
    6 Coldingham Place
    Garvock Hill
    KY12 7XS Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    6 Coldingham Place
    Garvock Hill
    KY12 7XS Dunfermline
    Fife
    United KingdomBritish663070001
    MAY, Christine Elizabeth Mary
    Cairngorm Crescent
    KY2 5RG Kirkcaldy
    27
    Fife
    Administrateur
    Cairngorm Crescent
    KY2 5RG Kirkcaldy
    27
    Fife
    ScotlandIrish,British51665990001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MEIKLEJOHN, Iain Maury Campbell
    14 Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    Administrateur désigné
    14 Dalrymple Crescent
    EH9 2NX Edinburgh
    British900003350001
    MORRISON, Alexander Charles
    Drum House
    Drum
    KY13 0UN Kinross
    Fife
    Administrateur
    Drum House
    Drum
    KY13 0UN Kinross
    Fife
    British806880001
    REID, Robert Paul, Sir
    24 Ashley Gardens
    Ambrosden Avenue
    SW1P 1QD London
    Administrateur
    24 Ashley Gardens
    Ambrosden Avenue
    SW1P 1QD London
    EnglandBritish2507910001
    ROBERTSON, Ian
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 Boswall Road
    EH5 3RH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish106197810002
    ROWLEY, Alexander Andrew Penman
    38 Mossgreen
    KY4 0AD Kelty
    Fife
    Administrateur
    38 Mossgreen
    KY4 0AD Kelty
    Fife
    ScotlandBritish48317740001
    SAUNDERS, Stewart Henry
    Blaenwern 13 Dean Park Gardens
    Chapel
    KY2 6XX Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    Blaenwern 13 Dean Park Gardens
    Chapel
    KY2 6XX Kirkcaldy
    Fife
    United KingdomBritish70345950001
    SMITH, Allan Keppie
    The Forts
    Hawes Brae
    EH30 9TE South Queensferry
    West Lothian
    Administrateur
    The Forts
    Hawes Brae
    EH30 9TE South Queensferry
    West Lothian
    British160830001
    SMITH, Terence Patrick
    Old Market Garden
    10 Ettrick Grove
    EH10 5AW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Old Market Garden
    10 Ettrick Grove
    EH10 5AW Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish27223670007
    TAYLOR, William Gordon, Director
    Hayston Park
    Quarry Road
    KY16 0AN Balmullo
    Fife
    Administrateur
    Hayston Park
    Quarry Road
    KY16 0AN Balmullo
    Fife
    ScotlandBritish96317990001
    THOMPSON, Hugh Macrae
    Fryern Barn
    Fryern Park
    RH20 4HG Storrington
    West Sussex
    Administrateur
    Fryern Barn
    Fryern Park
    RH20 4HG Storrington
    West Sussex
    British4959050005
    TITTERTON, David George
    8 Ermelo Gardens
    Lindsayfield
    G75 East Kilbride
    Scotland
    Administrateur
    8 Ermelo Gardens
    Lindsayfield
    G75 East Kilbride
    Scotland
    British60565540002
    WHYTE, Duncan
    4 Victoria Crescent
    G65 9BJ Kilsyth
    Lanarkshire
    Administrateur
    4 Victoria Crescent
    G65 9BJ Kilsyth
    Lanarkshire
    United KingdomBritish102248880001
    WILL, James Robert
    Myreside
    EH41 4JA Gifford
    East Lothian
    Administrateur désigné
    Myreside
    EH41 4JA Gifford
    East Lothian
    ScotlandBritish900003650001

    ROSYTH REGENERATION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 12 mars 2001
    Livré le 29 mars 2001
    En cours
    Montant garanti
    All sums due and that may become due under terms of bond and obligation
    Brèves mentions
    Area of ground forming the oilf fuel depot, east tip & st margarets marsh at rosyth, fife and extending to 71.789 hectares.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Defence
    Transactions
    • 29 mars 2001Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 12 mars 2001
    Livré le 29 mars 2001
    En cours
    Montant garanti
    £150,000
    Brèves mentions
    Area of ground forming the oil fuel depot, east tip & st maragrets marsh at rosyth, fife and extending to 71.789 hectares.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Defence
    Transactions
    • 29 mars 2001Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 16 févr. 1998
    Livré le 03 mars 1998
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Defence
    Transactions
    • 03 mars 1998Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 17 déc. 1997
    Livré le 29 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 déc. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)

    ROSYTH REGENERATION LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 sept. 2014Dissolved on
    13 sept. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Tim Alan Askham
    The Lexicon Mount Street
    M2 5NT Manchester
    practitioner
    The Lexicon Mount Street
    M2 5NT Manchester
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0