Aidan John HUGHES
Personne physique
Titre | Mr |
---|---|
Prénom | Aidan |
Deuxième prénom | John |
Nom de famille | HUGHES |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 5 |
Inactif | 1 |
Démissionné | 36 |
Total | 42 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROBE TEST HOLDINGS LIMITED | 01 août 2024 | Active | Chartered Accountant | Administrateur | 3 Lister Way Hamilton International Technology Park G72 0FT Glasgow Kintail House Scotland | England | British | |
MANZARA SOLUTIONS LIMITED | 25 janv. 2018 | Dissoute | Director | Administrateur | Gosforth Park Avenue NE12 8EG Newcastle Upon Tyne Rmt Accountants & Business Advisors Limited United Kingdom | England | British | |
FLINT TV EBT COMPANY LTD | 28 sept. 2017 | Active | Director | Administrateur | Gosforth Park Avenue NE12 8EG Newcastle Upon Tyne Rmt Accountants & Business Advisors Ltd England | England | British | |
FLINT TELEVISION LTD | 25 oct. 2016 | Active | Director | Administrateur | Gosforth Park Avenue NE12 8EG Newcastle Upon Tyne Rmt Accountants & Business Advisors Ltd England | England | British | |
SUBSTANCE 2005 LIMITED | 16 juin 2015 | Active | None | Administrateur | 24 Hood Street M4 6WX Manchester Suite G.04 Jactin House England | England | British | |
KIDS KABIN | 24 mai 2000 | Active | Accountant | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | |
CERES POWER HOLDINGS PLC | 09 févr. 2015 | 16 mai 2024 | Active | Director | Administrateur | Foundry Lane RH13 5PX Horsham Viking House West Sussex | England | British |
DIALOG SEMICONDUCTOR LIMITED | 01 oct. 2004 | 02 mai 2019 | Active | Director | Administrateur | Tower Bridge House St Katharine's Way E1W 1AA London | England | British |
CORELOGIC GLOBAL LIMITED | 25 mai 2010 | 11 févr. 2015 | Active | None | Administrateur | Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne The Crest England | England | British |
FINNMAC SOLUTIONS LIMITED | 17 août 2012 | 01 mai 2013 | Dissoute | Director | Administrateur | Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne The Crest United Kingdom | England | British |
APPLAUD WEB SOLUTIONS LIMITED | 02 déc. 2005 | 26 mai 2011 | Dissoute | Director | Secrétaire | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | |
APPLAUD WEB SOLUTIONS LIMITED | 02 juin 2005 | 26 mai 2011 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
ROZMIC WIRELESS LTD | 16 déc. 2005 | 11 sept. 2006 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
CL REALISATIONS LIMITED | 10 déc. 2001 | 31 août 2004 | En administration | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
CUK REALISATIONS LIMITED | 15 sept. 2003 | 03 août 2004 | En administration | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
KEN STOKES LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
LASER IMAGE LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
BLADES EAST AND BLADES LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
ROBOT NO. 7 LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
ROBOT NO. 4 LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
NEWJMTCO LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
YOMEGO LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
JOHN MANSFIELD TIMBER LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
ROBOT NO. 2 LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
MCCORQUODALE COLOUR DISPLAY LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
COMMUNISIS NI LTD | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne | England | British |
COMMUNISIS SECURITY PRODUCTS LTD | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
WAKEFIELD HOLDINGS LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
ROBOT NO. 5 LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
MCT (EXPORT) LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
STANDARD CHECK BOOK COMPANY LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
COMMUNISIS BBF LTD | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
JACARANDA PRODUCTIONS LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
ROBOT NO. 6 LIMITED | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
COMMUNISIS BROADPRINT LTD | 11 avr. 2002 | 03 août 2004 | Dissoute | Director | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0