NEWJMTCO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNEWJMTCO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 02397555
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NEWJMTCO LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe NEWJMTCO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Communisis House
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NEWJMTCO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SPRATLEY LIMITED22 juin 198922 juin 1989

    Quels sont les derniers comptes de NEWJMTCO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour NEWJMTCO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Steven Clive Rawlins en tant que directeur le 27 oct. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Timothy Austin Burgham en tant qu'administrateur le 27 oct. 2020

    2 pagesAP01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2019 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018

    3 pagesAA

    Nomination de Mr Steven Clive Rawlins en tant que secrétaire le 28 févr. 2019

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Steven Clive Rawlins en tant qu'administrateur le 28 févr. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sarah Louise Caddy en tant que secrétaire le 28 févr. 2019

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Sarah Louise Caddy en tant que directeur le 28 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Modification des détails de Communisis Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 déc. 2018

    2 pagesPSC05

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 août 2015

    État du capital au 04 août 2015

    • Capital: GBP 776,923
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 août 2014

    État du capital au 21 août 2014

    • Capital: GBP 776,923
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Sarah Louise Caddy le 15 août 2014

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de NEWJMTCO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RAWLINS, Steven Clive
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    England
    England
    Secrétaire
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    England
    England
    256484840001
    BURGHAM, Timothy Austin
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    England
    England
    Administrateur
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    England
    England
    United KingdomBritishFinance Director274846850001
    RIDDLE, Jonathan Rowlatt Huber
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    United Kingdom
    Administrateur
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    United Kingdom
    EnglandBritishTax Manager53609030001
    BEGLEY, Laurence
    Ash House
    Beechcroft Avenue
    ST16 1BJ Stafford
    Staffordshire
    Secrétaire
    Ash House
    Beechcroft Avenue
    ST16 1BJ Stafford
    Staffordshire
    BritishAccountant69297780001
    CADDY, Sarah Louise
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    United Kingdom
    146633110002
    HEADLEY, Jane Elizabeth
    Cotes House Farm
    Cotes Swynnerton
    ST15 0QQ Stone
    Staffordshire
    Secrétaire
    Cotes House Farm
    Cotes Swynnerton
    ST15 0QQ Stone
    Staffordshire
    British58949800001
    LINEHAM, Richard Henry
    33 Cherry Tree Avenue
    DE56 1FR Belper
    Derbyshire
    Secrétaire
    33 Cherry Tree Avenue
    DE56 1FR Belper
    Derbyshire
    British1550560001
    YOUNG, Martin Keay
    3 Penny Pot Gardens
    HG3 2GB Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    3 Penny Pot Gardens
    HG3 2GB Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Secretary41926620002
    BITTLESTONE, Anthony John
    Fairfield 108a Chapel Lane
    Ravenshead
    NG15 9DH Nottingham
    Administrateur
    Fairfield 108a Chapel Lane
    Ravenshead
    NG15 9DH Nottingham
    BritishChartered Accountant95926980001
    BUSHELL, Timothy Keith
    Blyth House
    St Ives
    PE17 3TQ Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Blyth House
    St Ives
    PE17 3TQ Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director19723360001
    CADDY, Sarah Louise
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    United Kingdom
    Administrateur
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary150731100003
    FISHER, Dean
    4 Marlpit Lane
    ST14 5HH Denstone
    Staffordshire
    Administrateur
    4 Marlpit Lane
    ST14 5HH Denstone
    Staffordshire
    BritishCompany Director127190290001
    HUGHES, Aidan John
    The Crest
    Smallburn
    NE20 0AD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    The Crest
    Smallburn
    NE20 0AD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritishDirector70055890002
    JARVIS, Bruce Edwin
    56 Redhill Lane
    Tutbury
    DE13 9JW Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    56 Redhill Lane
    Tutbury
    DE13 9JW Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Director20308470001
    LIPINSKI, Andrew Alexander, Mr.
    Old Brook House
    Brook End
    MK44 2HR Keysoe
    Bedfordshire
    Administrateur
    Old Brook House
    Brook End
    MK44 2HR Keysoe
    Bedfordshire
    United KingdomBritishDirector18079820001
    PAGE, Andrew Stephen
    44 The Grove
    MK40 3RN Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    44 The Grove
    MK40 3RN Bedford
    Bedfordshire
    BritishDirector47978190004
    PAYNE, Christopher John
    11 Baldwins Close
    CB3 7TH Bourn
    Cambridgeshire
    Administrateur
    11 Baldwins Close
    CB3 7TH Bourn
    Cambridgeshire
    BritishSalesman1550590002
    RAWLINS, Steven Clive
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    England
    England
    Administrateur
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    England
    England
    EnglandUnited KingdomCompany Director240837130001
    YOUNG, Martin Keay
    3 Penny Pot Gardens
    HG3 2GB Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    3 Penny Pot Gardens
    HG3 2GB Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Secretary41926620002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NEWJMTCO LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Communisis Limited
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    England
    06 avr. 2016
    Manston Lane
    LS15 8AH Leeds
    Communisis House
    England
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    NEWJMTCO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Collateral debenture
    Créé le 28 juin 1994
    Livré le 30 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from john mansfield group PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 30 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 06 juin 1991
    Livré le 12 juin 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 12 juin 1991Enregistrement d'une charge
    • 21 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of off set
    Créé le 04 août 1989
    Livré le 17 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from john mansfield timber limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All sums new standing or hereafter in the company's books.
    Personnes ayant droit
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 20 oct. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 04 août 1989
    Livré le 17 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade & tenant's fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 20 oct. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 04 août 1989
    Livré le 08 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC
    Transactions
    • 08 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 21 sept. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0