NEWJMTCO LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | NEWJMTCO LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 02397555 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NEWJMTCO LIMITED ?
Adresse du siège social | Communisis House Manston Lane LS15 8AH Leeds |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NEWJMTCO LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour NEWJMTCO LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Steven Clive Rawlins en tant que directeur le 27 oct. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Timothy Austin Burgham en tant qu'administrateur le 27 oct. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2019 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018 | 3 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Steven Clive Rawlins en tant que secrétaire le 28 févr. 2019 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Steven Clive Rawlins en tant qu'administrateur le 28 févr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sarah Louise Caddy en tant que secrétaire le 28 févr. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sarah Louise Caddy en tant que directeur le 28 févr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des détails de Communisis Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 déc. 2018 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2017 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2018 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 28 juil. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 28 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires | 8 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Sarah Louise Caddy le 15 août 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de NEWJMTCO LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAWLINS, Steven Clive | Secrétaire | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House England England | 256484840001 | |||||||
BURGHAM, Timothy Austin | Administrateur | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House England England | United Kingdom | British | Finance Director | 274846850001 | ||||
RIDDLE, Jonathan Rowlatt Huber | Administrateur | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House United Kingdom | England | British | Tax Manager | 53609030001 | ||||
BEGLEY, Laurence | Secrétaire | Ash House Beechcroft Avenue ST16 1BJ Stafford Staffordshire | British | Accountant | 69297780001 | |||||
CADDY, Sarah Louise | Secrétaire | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House United Kingdom | 146633110002 | |||||||
HEADLEY, Jane Elizabeth | Secrétaire | Cotes House Farm Cotes Swynnerton ST15 0QQ Stone Staffordshire | British | 58949800001 | ||||||
LINEHAM, Richard Henry | Secrétaire | 33 Cherry Tree Avenue DE56 1FR Belper Derbyshire | British | 1550560001 | ||||||
YOUNG, Martin Keay | Secrétaire | 3 Penny Pot Gardens HG3 2GB Harrogate North Yorkshire | British | Company Secretary | 41926620002 | |||||
BITTLESTONE, Anthony John | Administrateur | Fairfield 108a Chapel Lane Ravenshead NG15 9DH Nottingham | British | Chartered Accountant | 95926980001 | |||||
BUSHELL, Timothy Keith | Administrateur | Blyth House St Ives PE17 3TQ Huntingdon Cambridgeshire | British | Company Director | 19723360001 | |||||
CADDY, Sarah Louise | Administrateur | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House United Kingdom | England | British | Company Secretary | 150731100003 | ||||
FISHER, Dean | Administrateur | 4 Marlpit Lane ST14 5HH Denstone Staffordshire | British | Company Director | 127190290001 | |||||
HUGHES, Aidan John | Administrateur | The Crest Smallburn NE20 0AD Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | Director | 70055890002 | ||||
JARVIS, Bruce Edwin | Administrateur | 56 Redhill Lane Tutbury DE13 9JW Burton On Trent Staffordshire | British | Company Director | 20308470001 | |||||
LIPINSKI, Andrew Alexander, Mr. | Administrateur | Old Brook House Brook End MK44 2HR Keysoe Bedfordshire | United Kingdom | British | Director | 18079820001 | ||||
PAGE, Andrew Stephen | Administrateur | 44 The Grove MK40 3RN Bedford Bedfordshire | British | Director | 47978190004 | |||||
PAYNE, Christopher John | Administrateur | 11 Baldwins Close CB3 7TH Bourn Cambridgeshire | British | Salesman | 1550590002 | |||||
RAWLINS, Steven Clive | Administrateur | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House England England | England | United Kingdom | Company Director | 240837130001 | ||||
YOUNG, Martin Keay | Administrateur | 3 Penny Pot Gardens HG3 2GB Harrogate North Yorkshire | England | British | Company Secretary | 41926620002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NEWJMTCO LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communisis Limited | 06 avr. 2016 | Manston Lane LS15 8AH Leeds Communisis House England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
|
NEWJMTCO LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Collateral debenture | Créé le 28 juin 1994 Livré le 30 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from john mansfield group PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 06 juin 1991 Livré le 12 juin 1991 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Letter of off set | Créé le 04 août 1989 Livré le 17 août 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from john mansfield timber limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions All sums new standing or hereafter in the company's books. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 04 août 1989 Livré le 17 août 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Including trade & tenant's fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 04 août 1989 Livré le 08 août 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0