David William Murray HORNE
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | David |
Deuxième prénom | William Murray |
Nom de famille | HORNE |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 5 |
Inactif | 66 |
Démissionné | 129 |
Total | 200 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDLESHAW GODDARD LLP | 01 juin 2017 | Active | Membre de la LLP | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate United Kingdom | United Kingdom | |||
ADDLESHAW GODDARD (SCOTLAND) SERVICES LIMITED | 11 oct. 2012 | Active | Solicitor | Administrateur | Exchange Tower 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh | United Kingdom | British | |
ADDLESHAW GODDARD (SCOTLAND) SECRETARIAL LIMITED | 11 oct. 2012 | Active | Solicitor | Administrateur | Exchange Tower, 19 Canning Street, Edinburgh EH3 8EH Midlothian | United Kingdom | British | |
HYTEMP NICKEL ALLOYS LIMITED | 04 avr. 2008 | Dissoute | Secrétaire | Cobra Court, 1 Brightgate Way, Trafford Park M32 0TB Manchester Brightgate House England | British | |||
MMG SHELF 8 LIMITED | 03 janv. 2008 | Dissoute | Secrétaire | c/o C/O Gateley Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven England | British | |||
GROSVENOR HOUSE SOUTHAMPTON LIMITED | 15 nov. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
PARSON & CROSLAND (MIDDLESBROUGH) LIMITED | 31 oct. 2007 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | Torduff 2 Barnshot Road EH13 0DH Edinburgh Midlothian | British | ||
MMH P&C LIMITED | 31 oct. 2007 | Dissoute | Secrétaire | c/o C/O Gateley Llp Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven England | British | |||
NOVEMBER LEISURE LIMITED | 05 sept. 2007 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
PPG LAND THORNE LIMITED | 29 août 2007 | Dissoute | Secrétaire | c/o C/O Gateley Llp Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven England | British | |||
MMH NSS LIMITED | 01 févr. 2007 | Dissoute | Secrétaire | 1 Little New Street EC4A 3TR London Hill House | British | |||
PPG BRACKNELL LIMITED | 22 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | c/o C/O Gateley Llp Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven England | British | |||
RESPONSE CREDIT MANAGEMENT LIMITED | 13 oct. 2006 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
ULTIVEX LTD. | 04 sept. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 1 Brightgate Way Trafford Park M32 0TB Manchester Brightgate House Cobra Court | British | |||
TIPTON & MILL STEELS LIMITED | 04 sept. 2006 | Dissoute | Secrétaire | c/o C/O Gateley Llp Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven England | British | |||
CARNEGIE INFORMATION SYSTEMS LIMITED | 15 juin 2006 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
RHL SERVICES LIMITED | 18 mai 2006 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
PPG LAND NORMANTON LIMITED | 28 févr. 2006 | Dissoute | Secrétaire | c/o C/O Gateley Llp Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven England | British | |||
MMH ATP LIMITED | 27 janv. 2006 | Dissoute | Secrétaire | c/o C/O Gateley Llp Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven England | British | |||
ELEVEN HAYMARKET LIMITED | 31 mars 2005 | Dissoute | Secrétaire | c/o C/O Gateley Llp Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven England | British | |||
RYEFORD DEVELOPMENTS LIMITED | 11 janv. 2005 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
MATERIAL LOGISTICS LIMITED | 03 déc. 2004 | Dissoute | Secrétaire | c/o C/O Gateley Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven England | British | |||
PPG METRO MANSFIELD LIMITED | 30 nov. 2004 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
PPG METRO 500 LIMITED | 30 nov. 2004 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
BRETTON STREET DEVELOPMENTS LIMITED | 15 juil. 2004 | Dissoute | Secrétaire | c/o Gateley Llp Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven England | British | |||
MURRAY METALS CONSULTANCY LIMITED | 30 mars 2004 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
MURRAY METALS INVESTMENTS LIMITED | 30 mars 2004 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
PPG METRO 39 LIMITED | 30 mars 2004 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
BROGUE PROPERTIES LIMITED | 18 déc. 2003 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
PPG METRO GREENOCK LIMITED | 27 oct. 2003 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
PPG METRO CALEDONIAN LIMITED | 27 oct. 2003 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
TAKE TWO DEVELOPMENTS LIMITED | 23 sept. 2003 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
G M GROUP HOLDINGS LIMITED | 06 mai 2003 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
MALCOLM MCNEILL LIMITED | 23 août 2002 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | |||
PPG SOUTHERN LIMITED | 16 juil. 2002 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0