David William Murray HORNE - Page 3
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | David |
Deuxième prénom | William Murray |
Nom de famille | HORNE |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 5 |
Inactif | 66 |
Démissionné | 129 |
Total | 200 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRATCH TECHNOLOGIES LIMITED | 12 mars 1998 | Dissoute | Solicitor | Secrétaire | Torduff 2 Barnshot Road EH13 0DH Edinburgh Midlothian | British | ||
ADDLESHAW GODDARD (SCOTLAND) LLP | 01 juin 2011 | 01 juin 2017 | Active | Membre de la LLP | Exchange Tower 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh Midlothian | United Kingdom | ||
AZK99 LIMITED | 01 mai 2002 | 17 nov. 2014 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | ||
IRELAND ALLOYS LIMITED | 05 août 2004 | 26 sept. 2014 | Active | Secrétaire | Whistleberry Road ML3 0HP Hamilton Scotland | British | ||
RHL DIRECT LIMITED | 18 mai 2006 | 26 août 2014 | Active | Secrétaire | 21 Tyndrum Street G4 0JY Glasgow Citypoint | British | ||
RESPONSE (BUILDING REWARDING RELATIONSHIPS) LIMITED | 18 mai 2006 | 26 août 2014 | Active | Secrétaire | 21 Tyndrum Street G4 0JY Glasgow Citypoint | British | ||
RHL CONTACT CENTRE SERVICES LIMITED | 18 mai 2006 | 26 août 2014 | Active | Secrétaire | 21 Tyndrum Street G4 0JY Glasgow Citypoint | British | ||
BRETTON STREET DEVELOPMENTS MANAGEMENT COMPANY NO1 LIMITED | 08 juin 2006 | 09 juil. 2014 | Dissoute | Secrétaire | c/o Gateley Llp Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven England | British | ||
CHARLES AVENUE BURGESS HILL MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 28 oct. 2008 | 13 nov. 2013 | Active | Secrétaire | c/o C/O Gateley Edmund Street B3 2HJ Birmingham One Eleven England | British | ||
CONNECT 10 ESTATE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 28 oct. 2008 | 26 avr. 2013 | Active | Secrétaire | Carlos Place W1K 3AT London 9-10 England | British | ||
PREMIER HYTEMP HOLDINGS LIMITED | 25 juin 2007 | 30 nov. 2012 | Active | Secrétaire | Newbridge Industrial Estate EH28 8PJ Newbridge Midlothian | British | ||
PREMIER HYTEMP LIMITED | 01 mai 2002 | 30 nov. 2012 | Active | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | ||
HILLFOOT STEEL LIMITED | 04 avr. 2008 | 11 mai 2012 | Active | Secrétaire | 1 Brightgate Way Trafford Park M32 0TB Manchester Brightgate House Cobra Court | British | ||
MURRAY PLATE GROUP LIMITED | 31 juil. 2006 | 11 mai 2012 | Active | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | ||
MULTI METALS LIMITED | 11 juil. 2002 | 11 mai 2012 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | ||
FORTH STEEL LIMITED | 01 mai 2002 | 11 mai 2012 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | ||
COASTAL MARINE EYEMOUTH LIMITED | 12 déc. 2011 | 13 déc. 2011 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh Exchange Tower | United Kingdom | British |
COASTAL MARINE 2012 LIMITED | 23 nov. 2011 | 23 nov. 2011 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh Exchange Tower | United Kingdom | British |
WINE IMPORTERS (EDINBURGH) LIMITED | 13 déc. 2006 | 13 juil. 2011 | Active | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | ||
CHARDON WINES LIMITED | 29 nov. 2006 | 13 juil. 2011 | Active | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | ||
KINTILLO INVESTMENTS LIMITED | 15 juin 2005 | 13 juil. 2011 | Active | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 11 | British | ||
NH3 LIMITED | 01 mai 2002 | 13 juil. 2011 | Active | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | ||
DAVID MURRAY HOLDINGS LIMITED | 01 mai 2002 | 13 juil. 2011 | Dissoute | Secrétaire | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | British | ||
DUNWILCO (172) LIMITED | 01 mai 2002 | 13 juil. 2011 | Dissoute | Secrétaire | 9 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DR | British | ||
SCOR LIME STREET LIMITED | 01 mai 2002 | 06 juil. 2011 | Active | Secrétaire | Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh 15 | British | ||
NEW BRANNOCK INFRASTRUCTURE 1 LIMITED | 09 juin 2010 | 31 mai 2011 | Active | Solicitor | Administrateur | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | United Kingdom | British |
NEW BRANNOCK INFRASTRUCTURE 2 LIMITED | 09 juin 2010 | 31 mai 2011 | Active | Solicitor | Administrateur | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | United Kingdom | British |
NEW BRANNOCK INFRASTRUCTURE 3 LIMITED | 09 juin 2010 | 31 mai 2011 | Active | Solicitor | Administrateur | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | United Kingdom | British |
FREESPACE LIVING LIMITED | 30 janv. 2009 | 31 mai 2011 | Active | Solicitor | Administrateur | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | United Kingdom | British |
MURRAY ESTATES LOTHIAN LIMITED | 30 janv. 2009 | 31 mai 2011 | Active | Solicitor | Administrateur | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | United Kingdom | British |
NEW BRANNOCK LIMITED | 30 janv. 2009 | 31 mai 2011 | Active | Solicitor | Administrateur | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | United Kingdom | British |
KINGDOM PARK LIMITED | 30 janv. 2009 | 31 mai 2011 | Active | Solicitor | Administrateur | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | United Kingdom | British |
MURRAY ESTATES LIMITED | 26 janv. 2009 | 31 mai 2011 | Active | Solicitor | Administrateur | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | United Kingdom | British |
RFC INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 12 juil. 2010 | 31 mai 2011 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | United Kingdom | British |
MURRAY SPORTS LIMITED | 12 juil. 2010 | 31 mai 2011 | Dissoute | Solicitor | Administrateur | Charlotte Square EH2 4DR Edinburgh 10 | United Kingdom | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0