HP SECRETARIAL SERVICES LIMITED - Page 2
Dirigeant de société
| Nom | HP SECRETARIAL SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Est un dirigeant de société | Oui |
| Nominations | |
| Actif | 4 |
| Inactif | 8 |
| Démissionné | 366 |
| Total | 378 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
|---|---|---|---|---|---|
| WHITE LODGE FARM MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 09 sept. 2004 | 24 mars 2009 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| WOODSTOCK PARTNERS LIMITED | 19 janv. 2006 | 01 mars 2009 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| EDWARD SQUARE LIMITED | 18 mai 2006 | 27 févr. 2009 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| TRIGUARD UK LIMITED | 24 mai 2004 | 19 févr. 2009 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| CORBY MOTOR HOLDINGS LIMITED | 04 sept. 1997 | 19 févr. 2009 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| RESTRAIN COMPANY LIMITED | 29 mars 2004 | 15 déc. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| RIVERSIDE (OLNEY) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 15 avr. 2005 | 25 nov. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| CPOP LIMITED | 19 déc. 2007 | 24 nov. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| KASM LIMITED | 19 déc. 2007 | 24 nov. 2008 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| BOURNEMOUTH TPS LIMITED | 03 avr. 2007 | 24 nov. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| CAPITAL MOTOR COMPANY LIMITED | 03 avr. 2007 | 24 nov. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| STAFFORDSHIRE TRADE PARTS SPECIALISTS LIMITED | 02 janv. 2007 | 24 nov. 2008 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| ROBERT SIMS LIMITED | 12 juil. 2006 | 24 nov. 2008 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| PROGRESS BEDFORD LIMITED | 26 juin 2006 | 24 nov. 2008 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| FSG CAPITAL LIMITED | 26 oct. 2005 | 24 nov. 2008 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| LIBERTY CORPORATE FINANCE LIMITED | 26 oct. 2005 | 24 nov. 2008 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| LIBERTY FINANCIAL SOLUTIONS GROUP LIMITED | 26 oct. 2005 | 24 nov. 2008 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| E.F.B. TRUSTEES LIMITED | 14 juin 2005 | 24 nov. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| FEATHERFOAM LIMITED | 14 juin 2005 | 24 nov. 2008 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| NEW LINE METALS LIMITED | 23 mai 2005 | 24 nov. 2008 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| E.F.B. GROUP LIMITED | 20 mai 2005 | 24 nov. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| PR2 HOLDINGS LIMITED | 11 mai 2004 | 24 nov. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| PR2 SOLUTIONS LIMITED | 16 mars 2004 | 24 nov. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| DAVID JONES GARAGES LIMITED | 22 août 2002 | 24 nov. 2008 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| THOMPSON MOTOR COMPANY (PRESTON) LIMITED | 26 juin 2000 | 24 nov. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| BREEZE MOTOR COMPANY LIMITED | 09 mars 2000 | 24 nov. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| 599 MK CREATIVE CENTRE LIMITED | 20 déc. 1999 | 24 nov. 2008 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| EURO FOOD BRANDS LIMITED | 11 janv. 1991 | 24 nov. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| COMMODITY TRADING LIMITED | 24 nov. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire | |
| CHARTWELL CLOSE (PETERBOROUGH) MANAGEMENT (NO. 2) LIMITED | 18 déc. 2006 | 06 nov. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| ZAPATO FOOTWEAR UK LIMITED | 23 juin 2003 | 31 oct. 2008 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| CARMAZ LIMITED | 23 mai 2002 | 23 oct. 2008 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| HOWPER 602 LIMITED | 18 déc. 2006 | 08 oct. 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| ARKA FOODS LIMITED | 17 nov. 2004 | 07 oct. 2008 | Dissoute | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
| WOBURN HOUSE PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 20 déc. 2005 | 11 août 2008 | Active | Secrétaire désigné | Oxford House Cliftonville NN1 5PN Northampton Northamptonshire |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0