PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
  • Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED - Page 4

    Dirigeant de société

    NomPINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Est un dirigeant de sociétéOui
    Nominations
    Actif0
    Inactif0
    Démissionné276
    Total276

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéRôleAdresse
    OAKAPPLE HOMES LIMITED22 oct. 199802 nov. 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    GATE CAPITAL GROUP LTD.14 sept. 199828 oct. 1998ActiveSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    CC MOTORSTORES LIMITED16 oct. 199823 oct. 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    CARDO DOOR UK LIMITED01 juin 199809 oct. 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    SELECTA SHOWER PRODUCTS LIMITED01 déc. 199705 oct. 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    TOP COPY IMAGE CENTRES LIMITED22 juil. 199830 sept. 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    J C RATHBONE TRUSTEES LIMITED09 juin 199824 sept. 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    SESAME BANKHALL GROUP LIMITED01 juin 199804 sept. 1998ActiveSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (DRUMMOND) LIMITED26 mai 199804 sept. 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    HEITON HOLDINGS UK LIMITED22 juil. 199801 sept. 1998ActiveSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    WHITE ROSE RESEARCH LIMITED08 déc. 199726 août 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    ELMLEY ASSOCIATES LIMITED11 août 199817 août 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    YORK MAILING LIMITED16 juin 199817 août 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    PROLOGIS (PHL NO.3) LIMITED01 avr. 199814 août 1998ActiveSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    PARKRIDGE GATE DEVELOPMENTS LIMITED11 mai 199814 août 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    CONTINENTAL CONVEYOR LIMITED24 juin 199831 juil. 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    TRIADA, LTD09 juin 199820 juil. 1998LiquidationSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    VALENTIA AIR LIMITED26 mai 199809 juil. 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    WHESSOE PIPING SYSTEMS LIMITED01 juin 199825 juin 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    AITON & CO LIMITED01 juin 199825 juin 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    XANTHOUS 12 LIMITED17 mars 199822 juin 1998ActiveSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (CHURCHFIELDS) LIMITED26 mai 199819 juin 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    MED DEV SYSTEMS LIMITED26 mai 199809 juin 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    SUNRISE MEDICAL LIMITED26 mai 199805 juin 1998ActiveSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    MAN-FIDEX LIMITED31 mars 199805 juin 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    PRECISION ENGINEERING INTERNATIONAL TRUSTEE LIMITED01 avr. 199802 juin 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    PENDRAGON QUEST TRUSTEES LIMITED12 févr. 199801 juin 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    AVLAR LIMITED01 avr. 199818 mai 1998ActiveSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    TURNER & TOWNSEND EUROPE LIMITED20 févr. 199830 avr. 1998ActiveSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    TURNER & TOWNSEND UK LIMITED18 févr. 199830 avr. 1998ActiveSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    T P PROPERTY SERVICES LIMITED18 févr. 199824 avr. 1998ActiveSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    ELKSTONE HOLDINGS LTD24 déc. 199723 avr. 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    MOVES GROUP LIMITED12 févr. 199831 mars 1998ActiveSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    ISS SERVISYSTEM MIDLANDS LIMITED17 mars 199825 mars 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    INTERACT TRUSTEES LIMITED08 avr. 199713 mars 1998DissouteSecrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0