• Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • David FLINT

    Personne physique

    Titre
    PrénomDavid
    Nom de familleFLINT
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif2
    Inactif0
    Démissionné231
    Total233

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    W.J.HARTE (CITY) LIMITED17 mai 1988Receveur désignéSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    W.J.HARTE (CITY) LIMITED17 mai 1988Receveur désignéAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    CLYDE MATERIALS HANDLING LIMITED05 sept. 199628 juil. 2000DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    CLYDE MATERIALS HANDLING LIMITED05 sept. 199628 juil. 2000DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    GRAMPIAN OAT PRODUCTS LIMITED04 juil. 199704 juil. 1998ActiveAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    HUNA DEVELOPMENT LIMITED21 mars 199728 nov. 1997ActiveSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    HUNA DEVELOPMENT LIMITED21 mars 199728 nov. 1997ActiveAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    INVERNESS AIR TERMINAL LIMITED23 janv. 199721 nov. 1997DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    INVERNESS AIR TERMINAL LIMITED23 janv. 199721 nov. 1997DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    MACROCOM (422) LIMITED28 mai 199722 sept. 1997LiquidationAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    MACROCOM (422) LIMITED28 mai 199722 sept. 1997LiquidationSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    EMPACE LIMITED09 juin 199709 sept. 1997DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    EMPACE LIMITED09 juin 199709 sept. 1997DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    AYR ESTATES LIMITED04 juil. 199702 sept. 1997DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    AYR ESTATES LIMITED04 juil. 199702 sept. 1997DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    GRAMPIAN OAT PRODUCTS LIMITED04 juil. 199713 août 1997ActiveSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    HAMLYNS OF SCOTLAND LIMITED04 juil. 199713 août 1997ActiveAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    HAMLYNS OF SCOTLAND LIMITED04 juil. 199713 août 1997ActiveSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    SOMERSTON HOTELS (FIVE) LIMITED08 mai 199724 juin 1997DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    SOMERSTON HOTELS (FIVE) LIMITED08 mai 199724 juin 1997DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    INDIGO LIGHTHOUSE SOLUTIONS LIMITED09 juin 199718 juin 1997ActiveSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    INDIGO LIGHTHOUSE SOLUTIONS LIMITED09 juin 199718 juin 1997ActiveAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    LCM123 LIMITED08 mai 199702 juin 1997DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    LCM123 LIMITED08 mai 199702 juin 1997DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    INDIGO LIGHTHOUSE GROUP LIMITED28 mai 199730 mai 1997ActiveAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    INDIGO LIGHTHOUSE GROUP LIMITED28 mai 199730 mai 1997ActiveSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    MACROCOM (419) LIMITED08 mai 199721 mai 1997DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    MACROCOM (419) LIMITED08 mai 199721 mai 1997DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    GLENFESHIE SEAFOODS LIMITED21 mars 199729 avr. 1997DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    GLENFESHIE SEAFOODS LIMITED21 mars 199729 avr. 1997DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    SILVER CHOICE TRAVEL LIMITED23 janv. 199728 avr. 1997DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    SILVER CHOICE TRAVEL LIMITED23 janv. 199728 avr. 1997DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    SLEAFORD POWER LIMITED13 févr. 199709 avr. 1997DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    SLEAFORD POWER LIMITED13 févr. 199709 avr. 1997DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    BRITISH ENERGY FINANCE LIMITED21 mars 199708 avr. 1997DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0