• Données
  • Grande-Bretagne
  • Entreprises
  • Rechercher des entreprises
  • Sanctions
  • Rechercher des sanctions
  • David FLINT - Page 6

    Personne physique

    Titre
    PrénomDavid
    Nom de familleFLINT
    Date de naissance
    Est un dirigeant de sociétéNon
    Nominations
    Actif2
    Inactif0
    Démissionné231
    Total233

    Nominations

    Dirigeants nommés
    Nommé(e) àDate de nominationDate de démissionStatut de la sociétéProfessionRôleAdressePays de résidenceNationalité
    HAIRDRESSING SUPPLIES LIMITED20 nov. 199227 janv. 1993LiquidationAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    HAIRDRESSING SUPPLIES LIMITED20 nov. 199227 janv. 1993LiquidationSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    THE CRANLEIGH BRICK AND TILE COMPANY LIMITED20 nov. 199202 déc. 1992DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    THE CRANLEIGH BRICK AND TILE COMPANY LIMITED20 nov. 199202 déc. 1992DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    TELEVISUAL DATA LIMITED01 juil. 199206 juil. 1992DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    TELEVISUAL DATA LIMITED01 juil. 199206 juil. 1992DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    CUMBRIA BEARINGS & TRANSMISSIONS LIMITED18 avr. 198918 avr. 1992DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    THE JOHNSTON PRESS TRUSTEE COMPANY LIMITED18 oct. 199109 avr. 1992DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    THE JOHNSTON PRESS TRUSTEE COMPANY LIMITED18 oct. 199109 avr. 1992DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    T.S. MCNEE LIMITED21 févr. 199206 avr. 1992DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    T.S. MCNEE LIMITED21 févr. 199206 avr. 1992DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    APERTA LIMITED21 févr. 199212 mars 1992ActiveAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    APERTA LIMITED21 févr. 199212 mars 1992ActiveSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    MEDIA MANAGEMENT (UK) LIMITED18 déc. 199112 mars 1992DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    MEDIA MANAGEMENT (UK) LIMITED18 déc. 199112 mars 1992DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    P. MCKENNA & SONS (TRANSPORT SERVICES) LIMITED25 mars 199104 mars 1992DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    CORE IMAGE LIMITED18 oct. 199110 janv. 1992ActiveAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    CORE IMAGE LIMITED18 oct. 199110 janv. 1992ActiveSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    PAPINGO LIMITED13 déc. 198813 déc. 1991DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    PAPINGO LIMITED13 déc. 198813 déc. 1991DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    BARCLAY PROPERTY INVESTMENTS 2004 LTD.30 sept. 199109 oct. 1991ActiveSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    BARCLAY PROPERTY INVESTMENTS 2004 LTD.30 sept. 199109 oct. 1991ActiveAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    ANALYTICAL SERVICES CENTRE (FOOD PARK) LIMITED25 sept. 199107 oct. 1991DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    ANALYTICAL SERVICES CENTRE (FOOD PARK) LIMITED25 sept. 199107 oct. 1991DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    TECHNOLOGY TRANSFER CENTRE LIMITED06 août 199116 sept. 1991DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    TECHNOLOGY TRANSFER CENTRE LIMITED06 août 199116 sept. 1991DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    LEES GROUP LIMITED17 sept. 199009 sept. 1991ActiveSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    LEES GROUP LIMITED17 sept. 199009 sept. 1991ActiveAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    BOTHWELL PARK BRICK COMPANY LIMITED15 mars 198806 août 1991LiquidationAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    BOTHWELL PARK BRICK COMPANY LIMITED15 mars 198806 août 1991LiquidationSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    STRATTON CONSULTANCY SERVICES LIMITED13 déc. 198814 juin 1991DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    STRATTON CONSULTANCY SERVICES LIMITED13 déc. 198814 juin 1991DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    FEATHER BROOKSBANK LIMITED17 sept. 199008 nov. 1990DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    FEATHER BROOKSBANK LIMITED17 sept. 199008 nov. 1990DissouteAdministrateur désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British
    HIGHMORE HOMES NORTH LIMITED16 mars 198914 sept. 1990DissouteSecrétaire désigné
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    British

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0