Susan Elisabeth MARSDEN - Page 5
Personne physique
| Titre | |
|---|---|
| Prénom | Susan |
| Deuxième prénom | Elisabeth |
| Nom de famille | MARSDEN |
| Est un dirigeant de société | Non |
| Nominations | |
| Actif | 0 |
| Inactif | 0 |
| Démissionné | 196 |
| Total | 196 |
Nominations
| Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRACULA EXPERIENCE LIMITED | 24 avr. 2002 | 24 avr. 2002 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| TERROR TOWERS LIMITED | 24 avr. 2002 | 24 avr. 2002 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| APPETITE FOR LIFE LIMITED | 12 janv. 2001 | 18 avr. 2002 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| ABBOTTS (SHARLSTON) LIMITED | 11 avr. 2002 | 11 avr. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| THE FRANKLYN (DEVELOPMENTS) LIMITED | 22 févr. 2002 | 21 mars 2002 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| THE FRANKLYN (LONG TERM CARE) LIMITED | 17 déc. 2001 | 21 mars 2002 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| THE FRANKLYN GROUP LIMITED | 14 déc. 2001 | 21 mars 2002 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| AZZURRI MOTO LIMITED | 20 mars 2002 | 20 mars 2002 | Dissoute | Administrateur | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| SPECIALIST CEILING SERVICES HOLDINGS LIMITED | 13 mars 2002 | 13 mars 2002 | Active | Administrateur | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| GOWA LTD. | 19 févr. 2002 | 28 févr. 2002 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| BY CONSULTING LIMITED | 27 févr. 2002 | 27 févr. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| HARGREAVES TRAINING (HOLDINGS) LIMITED | 28 janv. 2002 | 28 janv. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| PLANET PLATFORMS (WESTERN) LIMITED | 10 janv. 2002 | 10 janv. 2002 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| SELECT FIREPLACES BEVERLEY LIMITED | 04 déc. 2001 | 04 déc. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| BRIO PIZZA LIMITED | 05 nov. 2001 | 05 nov. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| LOG CABIN (UK) LIMITED | 26 oct. 2001 | 26 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| BPM PHOENIX LIMITED | 10 oct. 2001 | 10 oct. 2001 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| JOHN RHODES & SON (IRONFOUNDERS) LIMITED | 26 sept. 2001 | 26 sept. 2001 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| S.O.S. COMMUNICATIONS LIMITED | 26 sept. 2001 | 26 sept. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| T.J. TIMBER LIMITED | 28 août 2001 | 28 août 2001 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| LINFIT DEVELOPMENTS LIMITED | 28 août 2001 | 28 août 2001 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| G.A.K. PROPERTIES LIMITED | 15 août 2001 | 15 août 2001 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| TAYLOR HUGHES LIMITED | 09 mai 2001 | 19 juil. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| A. C. FABRICATIONS LIMITED | 03 août 2000 | 30 juin 2001 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| R M UK SECURITIES LIMITED | 14 août 2000 | 28 juin 2001 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| BIG BANG LEISURE LIMITED | 18 mai 2001 | 18 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| CALDERGATE DEVELOPMENTS LIMITED | 27 avr. 2001 | 18 juin 2001 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| P K TEASDALE (ELECTRICAL) LIMITED | 07 juin 2001 | 07 juin 2001 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| ACCESS ENGINEERING LIMITED | 30 mai 2001 | 30 mai 2001 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| TEAM DEVELOPMENTS LIMITED | 29 mai 2001 | 29 mai 2001 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| SCS SPECIAL PROJECTS LIMITED | 08 mai 2001 | 08 mai 2001 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| TEAM (IMPRESSION) LIMITED | 02 mai 2001 | 02 mai 2001 | Active | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| COOLIST UK LIMITED | 29 mars 2001 | 30 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| GLYFADA LIMITED | 21 mars 2001 | 21 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British | ||
| PJS MUSIC SERVICES LIMITED | 21 mars 2001 | 21 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire | 356 Barnsley Road WF2 6BH Wakefield West Yorkshire | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0