John Charles Patrick MURPHY - Page 2
Personne physique
Titre | |
---|---|
Prénom | John |
Deuxième prénom | Charles Patrick |
Nom de famille | MURPHY |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 0 |
Démissionné | 206 |
Total | 206 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERTFORD (T) HAIRDRESSING LIMITED | 23 avr. 1999 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY NORTH LIMITED | 01 avr. 1999 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
ESSENSUALS GROUP LIMITED | 01 avr. 1999 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (BURY ST EDMUNDS) LIMITED | 16 déc. 1998 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
NEWBURY (T) HAIRDRESSING LIMITED | 23 oct. 1998 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
PUTNEY (T) HAIRDRESSING LIMITED | 11 août 1998 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
STYLE GROUP LIMITED | 11 août 1998 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
CHICHESTER (T) HAIRDRESSING LIMITED | 11 août 1998 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
INNOVIA DESIGN LIMITED | 11 août 1998 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
MASCOLO LIMITED | 11 août 1998 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
COLCHESTER (T) HAIRDRESSING LIMITED | 11 août 1998 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY LIMITED | 11 août 1998 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (SOUTH) LIMITED | 11 août 1998 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
LEAMINGTON SPA (T) HAIRDRESSING LIMITED | 11 août 1998 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
BRISTOL (T) HAIRDRESSING LIMITED | 11 août 1998 | 07 nov. 2006 | Active | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (GLASGOW ST VINCENT STREET) LIMITED | 10 juil. 2006 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (DUDLEY) LIMITED | 06 juil. 2006 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (HANLEY) LIMITED | 03 juil. 2006 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (LEICESTER) LIMITED | 08 juin 2006 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
ORPINGTON (E2) HAIRDRESSING LIMITED | 27 mars 2006 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (LEASE HESWALL) LIMITED | 22 févr. 2006 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (GLOUCESTER 2) LIMITED | 20 févr. 2006 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
BLUEWATER SALON LIMITED | 11 janv. 2006 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (LEASE BARNSTAPLE) LIMITED | 04 janv. 2006 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (LEASE MERRY HILL) LIMITED | 04 janv. 2006 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (HORSHAM) LIMITED | 01 nov. 2005 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
SURBITON SALON LIMITED | 30 sept. 2005 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (SLOUGH) LIMITED | 02 août 2005 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
MANSFIELD SALON LIMITED | 28 juin 2005 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (PETERBOROUGH 2) LIMITED | 14 juin 2005 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
CHIMES HAIRDRESSING LIMITED | 01 juin 2005 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (WIMBLEDON) LIMITED | 25 mai 2005 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (VICTORIA 2) LIMITED | 23 mai 2005 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
HEREFORD (T) HAIRDRESSING LIMITED | 16 mai 2005 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British | ||
TONI & GUY (ORMSKIRK) LIMITED | 16 mai 2005 | 07 nov. 2006 | Dissoute | Secrétaire | 27 Longhook Gardens UB5 6PF Northolt Middlesex | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0