K & S SECRETARIES LIMITED - Page 3
Dirigeant de société
Nom | K & S SECRETARIES LIMITED |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 4 |
Démissionné | 167 |
Total | 171 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
HENSON HOLDINGS LIMITED | 03 août 2001 | 19 déc. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
VODAFONE BUSINESS SERVICES LIMITED | 13 nov. 2001 | 17 déc. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
CAPITAL LOGISTICS LIMITED | 06 févr. 2001 | 11 déc. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
FKW LIMITED | 21 sept. 2001 | 30 oct. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
COSTESSY LIMITED | 16 mars 1999 | 25 oct. 2001 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
MILL COURT MANAGEMENT COMPANY (TRENTHAM) LIMITED | 03 août 2001 | 28 sept. 2001 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
BET365 GROUP LIMITED | 26 juin 2001 | 25 sept. 2001 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
MANCHESTER METROPOLITAN ESTATES LIMITED | 12 mars 2001 | 19 sept. 2001 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
BROCKLEHURST BUILDERS LIMITED | 26 juin 2001 | 24 juil. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
PRICE STREET 1 LIMITED | 12 mars 2001 | 23 juil. 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
ISS TECHNICAL SERVICES UK LIMITED | 27 avr. 2001 | 23 juil. 2001 | Liquidation | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
THE FINANCIAL INVESTIGATIONS AND RECEIVABLES MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 27 avr. 2001 | 26 juin 2001 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
MUST HAVE IT LIMITED | 12 mars 2001 | 15 mai 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
HILLSYDE FOUNDRY (STAFFORDSHIRE) LIMITED | 19 mai 2000 | 30 avr. 2001 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
HILLSIDE (NEW MEDIA HOLDINGS) LIMITED | 27 déc. 2000 | 27 avr. 2001 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
K & S (408) LIMITED | 26 févr. 2001 | 26 avr. 2001 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
A.B.M. CATERING LIMITED | 26 févr. 2001 | 26 avr. 2001 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
OAKMOOR ESTATES LIMITED | 12 mars 2001 | 27 mars 2001 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
OAKMOOR STUDENT INVESTMENTS LTD | 12 mars 2001 | 27 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
OAKMOOR HOMES LIMITED | 12 mars 2001 | 27 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
TARBERT TECHNOLOGIES LIMITED | 06 févr. 2001 | 08 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
ISS TECHNICAL SERVICES REGIONS LIMITED | 06 févr. 2001 | 08 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
PRICE STREET 2 LIMITED | 06 févr. 2001 | 08 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
ISS TECHNICAL SOLUTIONS LIMITED | 27 déc. 2000 | 08 mars 2001 | Liquidation | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
ALE PROJECTS LIMITED | 24 août 1999 | 26 févr. 2001 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
IONIC POWER LIMITED | 27 déc. 2000 | 10 janv. 2001 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
FUCHS LUBRITECH INTERNATIONAL LIMITED | 19 mai 2000 | 01 sept. 2000 | Liquidation | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
NEW ENGLAND KITCHENS & BEDROOMS LIMITED | 10 juil. 2000 | 24 juil. 2000 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
KEELE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED | 10 juil. 2000 | 24 juil. 2000 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
MANOR FARMS TRADING LIMITED | 06 avr. 2000 | 07 juin 2000 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
HILLSIDE (SHARED SERVICES) LIMITED | 28 mars 2000 | 02 juin 2000 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
WOOD MITCHELL & CO LIMITED | 02 déc. 1999 | 29 mars 2000 | Active | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
CHESHIRE NEWSPAPERS LIMITED | 16 mars 1999 | 11 nov. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
HILL BROTHERS GROUP LIMITED | 16 mars 1999 | 11 nov. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
RADIAL PARK DEVELOPMENTS LIMITED | 23 juil. 1997 | 05 nov. 1999 | Dissoute | Secrétaire désigné | The Brampton ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme Staffordshire |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0