Philippa Anne KEITH - Page 13
Personne physique
Titre | Mrs |
---|---|
Prénom | Philippa |
Deuxième prénom | Anne |
Nom de famille | KEITH |
Date de naissance | |
Est un dirigeant de société | Non |
Nominations | |
Actif | 17 |
Inactif | 22 |
Démissionné | 412 |
Total | 451 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Profession | Rôle | Adresse | Pays de résidence | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN SITU SPATIAL DESIGN LIMITED | 13 juil. 2010 | 13 juil. 2010 | Dissoute | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
DRUVA EUROPE LIMITED | 06 juil. 2010 | 06 juil. 2010 | Active | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
CENTAUR CONSUMER EXHIBITIONS LIMITED | 07 juin 2010 | 06 juil. 2010 | Dissoute | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
MAMMOTH SCREEN (MONROE) LIMITED | 24 juin 2010 | 24 juin 2010 | Dissoute | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
COVENTRY RESIDENCES LIMITED | 24 juin 2010 | 24 juin 2010 | Dissoute | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
CHARGE PRODUCTIONS UK LIMITED | 18 mai 2010 | 18 mai 2010 | Dissoute | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
FLAGSHIP ASSET FINANCE LIMITED | 12 mai 2010 | 12 mai 2010 | Liquidation | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
TALINVEST LIMITED | 11 mai 2010 | 11 mai 2010 | Dissoute | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
SOVEREIGN MINES OF NIGER LIMITED | 21 avr. 2010 | 21 avr. 2010 | Dissoute | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
SCARAB DISTRIBUTED ENERGY LIMITED | 06 avr. 2010 | 06 avr. 2010 | Dissoute | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
PRANA CORPORATE LIMITED | 23 mars 2010 | 23 mars 2010 | Dissoute | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
EROS ENERGY LIMITED | 19 mars 2010 | 19 mars 2010 | Dissoute | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
LEFT BANK PICTURES (DCI BANKS) LIMITED | 16 mars 2010 | 16 mars 2010 | Active | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
LUCS BRASSERIE LIMITED | 12 mars 2010 | 12 mars 2010 | Active | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
GRESHAM STREET RESTAURANT LIMITED | 12 mars 2010 | 12 mars 2010 | Dissoute | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
MAMMOTH SCREEN (NI) LIMITED | 11 mars 2010 | 11 mars 2010 | Dissoute | None | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | United Kingdom | British |
CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 13 mars 2007 | 15 oct. 2009 | Active | Secrétaire | Eastcastle Street W1W 8DH London 27/28 United Kingdom | British | ||
MSP SECRETARIES LIMITED | 13 mars 2007 | 20 févr. 2009 | Active | Secrétaire | The Green House 83 High Street RH9 8DT Godstone Surrey | British | ||
FERREXPO PLC | 18 juil. 2005 | 29 juil. 2006 | Active | Secrétaire | The Green House 83 High Street RH9 8DT Godstone Surrey | British | ||
FERREXPO PLC | 22 avr. 2005 | 29 juil. 2006 | Active | Chartered Secretary | Administrateur | The Green House 83 High Street RH9 8DT Godstone Surrey | United Kingdom | British |
APEX CORPORATE AND BUSINESS SERVICES UK LIMITED | 08 mars 2005 | 29 juil. 2006 | Active | Chartered Secretary | Secrétaire | The Green House 83 High Street RH9 8DT Godstone Surrey | British | |
AP CAPITAL PARTNERS LIMITED | 11 févr. 2005 | 29 juil. 2006 | Active | Chartered Secretary | Administrateur | The Green House 83 High Street RH9 8DT Godstone Surrey | United Kingdom | British |
THROGMORTON NOMINEES LLP | 18 oct. 2005 | 29 juil. 2006 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | The Green House 83 High Street RH9 8DT Godstone | United Kingdom | ||
KILIMANJARO DIRECTORS LLP | 18 oct. 2005 | 29 juil. 2006 | Dissoute | Membre désigné de la LLP | The Green House 83 High Street RH9 8DT Godstone | United Kingdom | ||
BERKELEY SQUARE SERVICES LIMITED | 17 mai 2005 | 29 juil. 2006 | Dissoute | Chartered Secretary | Administrateur | The Green House 83 High Street RH9 8DT Godstone Surrey | United Kingdom | British |
INTRINSIC CAPITAL SERVICES LIMITED | 11 mai 2005 | 01 juin 2006 | Active | Chartered Secretary | Administrateur | The Green House 83 High Street RH9 8DT Godstone Surrey | United Kingdom | British |
INTRINSIC CAPITAL LLP | 17 mars 2005 | 01 juin 2006 | Active | Membre désigné de la LLP | The Green House 83 High Street RH9 8DT Godstone | United Kingdom | ||
CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 22 janv. 1992 | 13 avr. 2005 | Active | Secrétaire | 47 Wycliffe Road Wimbledon SW19 1ES London | British | ||
MIDDLE EAST INVESTMENTS SOLUTIONS PLC | 01 oct. 1996 | 06 mars 2001 | Dissoute | Secrétaire | 47 Wycliffe Road Wimbledon SW19 1ES London | British | ||
AMBRIAN PLC | 24 mai 1996 | 27 févr. 2001 | Dissoute | Secrétaire | 47 Wycliffe Road Wimbledon SW19 1ES London | British | ||
XENETIC BIOSCIENCES (UK) LIMITED | 12 sept. 1996 | 20 oct. 2000 | Active | Secrétaire | 47 Wycliffe Road Wimbledon SW19 1ES London | British |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0