MACROBERTS - (FIRM) - Page 3
Dirigeant de société
Nom | MACROBERTS - (FIRM) |
---|---|
Est un dirigeant de société | Oui |
Nominations | |
Actif | 0 |
Inactif | 3 |
Démissionné | 212 |
Total | 215 |
Nominations
Nommé(e) à | Date de nomination | Date de démission | Statut de la société | Rôle | Adresse |
---|---|---|---|---|---|
EAST & WEST MILLS LIMITED | 29 oct. 2004 | 11 nov. 2004 | Active | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
W & J KNOX LIMITED | 18 août 2004 | 26 oct. 2004 | Active | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
MACROCOM (882) LIMITED | 18 août 2004 | 07 oct. 2004 | Active | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
HOWCO SPECIAL PROCESSING LIMITED | 18 août 2004 | 06 oct. 2004 | Active | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
PEKINO LIMITED | 18 août 2004 | 16 sept. 2004 | Active | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
JDC (TRUSTEE) LIMITED | 15 avr. 2003 | 03 sept. 2004 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
THE SANDHURST BUILDING LIMITED | 21 juin 2004 | 12 août 2004 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
ICE BLUE CONCEPTS LIMITED | 21 juin 2004 | 29 juil. 2004 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
MALCOLM OF BROOKFIELD LIMITED | 21 juin 2004 | 22 juil. 2004 | Active | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
LANARKSHIRE INITIATIVES LIMITED | 09 mars 2004 | 16 juin 2004 | Active | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
LITTLE BEANS LIMITED | 09 mars 2004 | 03 juin 2004 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
ALBATRANS (UK) LIMITED | 11 juin 2003 | 28 mai 2004 | Active | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
ROBISON & DAVIDSON TRUSTEES LIMITED | 29 mars 2004 | 25 mai 2004 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
LANDCOVE (AYR) LIMITED | 04 août 2003 | 25 mai 2004 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
ALTUS POST LTD | 11 juin 2003 | 25 mai 2004 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
WRL 13 LIMITED | 09 oct. 2003 | 10 mai 2004 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
VENTURE ASSOCIATES LIMITED | 09 oct. 2003 | 21 avr. 2004 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
OCEANAIR TRAVEL (UK) LIMITED | 11 juin 2003 | 31 mars 2004 | Active | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
LISTENING LIMITED | 09 mars 2004 | 21 mars 2004 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
MACROCOM (848) LIMITED | 04 août 2003 | 24 févr. 2004 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
SKYLINE PRINTING COMPANY LIMITED | 04 août 2003 | 16 févr. 2004 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
MACROCOM (840) LIMITED | 11 juin 2003 | 02 oct. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
BSOLVE LIMITED | 02 avr. 2003 | 23 juil. 2003 | Active | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
AILSA TH LIMITED | 12 mai 2003 | 16 juin 2003 | Active | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
ALBA ENGINEERING DESIGN LIMITED | 28 mars 2003 | 29 mai 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
GLENVARIGILL SPORTS CARS LIMITED | 12 mai 2003 | 22 mai 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
D A MACDONALD (CONTRACTORS) LIMITED | 09 avr. 2003 | 21 mai 2003 | Active | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
MWF PROJECTS LIMITED | 20 févr. 2003 | 16 avr. 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
R & D MECHANICAL & ELECTRICAL LIMITED | 25 sept. 2002 | 28 mars 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
R & D MANUFACTURING LIMITED | 25 sept. 2002 | 28 mars 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
DENHOLM 9SJ LIMITED | 20 févr. 2003 | 26 mars 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
HBG WELLGATE HOLDINGS LIMITED | 23 déc. 2002 | 18 mars 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
HBG PROPERTIES WELLGATE LIMITED | 23 déc. 2002 | 18 mars 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
COLLECTIVE ARCHITECTURE LIMITED | 25 nov. 2002 | 07 mars 2003 | Active | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
TRIPTYCH DEVELOPMENTS LIMITED | 21 mai 2002 | 07 mars 2003 | Dissoute | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0